KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05507040 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED?
| Dirección de la sede social | 12 St. James's Square SW1Y 4LB London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GE REAL ESTATE TRADING LIMITED | 02 abr 2007 | 02 abr 2007 |
| GE CFS (INVESTMENT PROPERTIES) LIMITED | 13 jul 2005 | 13 jul 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Raymond Annel Marquis como director el 17 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Michael Warnes como director el 31 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Coral Suzanne Bidel como director el 31 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Sanne Group Secretaries (Uk) Limited como secretario el 31 ene 2020 | 1 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Asticus Building 21 Palmer Street London SW1H 0AD England a 12 st. James's Square London SW1Y 4LB el 03 dic 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Raymond Annel Marquis como director el 15 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Panayot Kostadinov Vasilev como director el 15 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Gemma Nandita Kataky como director el 15 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Simon David Austin Davies como director el 15 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Emma Jane Morton como director el 15 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cessation de Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 jul 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Blackstone Group L.P en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 jul 2019 | 1 páginas | PSC02 | ||
Cese del nombramiento de Jason Christopher Bingham como director el 01 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Miss Coral Suzanne Bidel como director el 01 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 12 páginas | AA | ||
Notification de Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 oct 2018 | 2 páginas | PSC01 | ||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov 2018 | 2 páginas | PSC09 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 12 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 14 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTON, Emma Jane | Director | St James' Square SW1Y 4LB London 12 United Kingdom | England | British | 264422520001 | |||||||||
| BAMBER, Janine Margaret | Secretario | 105 Shepperton Road N1 3DF London | British | 117898690002 | ||||||||||
| BROWN, Grace | Secretario | 35 Corringham Road Wembley Park HA9 9PX Wembley Middlesex | British | 102074060001 | ||||||||||
| SLOCOMBE, Stephen Roy | Secretario | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England | British | 55097590003 | ||||||||||
| SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building England |
| 175738460001 | ||||||||||
| SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England |
| 175738460001 | ||||||||||
| TRUSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||||||
| ABRAMSON, Christoffer | Director | 37-39 Abingdon Road Flat 2 W8 6AH London | Swedish | 98463110005 | ||||||||||
| BIDEL, Coral Suzanne | Director | St. James's Square SW1Y 4LB London 12 England | United Kingdom | British | 179297460002 | |||||||||
| BINGHAM, Jason Christopher | Director | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building England | England | British | 225343320001 | |||||||||
| BOTHA, Stephanie | Director | 5 Highbridge Wharf Highbridge SE10 9PS London | American | 116663740001 | ||||||||||
| BOWDEN, Matthew Neville | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 183344960001 | |||||||||
| BRADLEY, Michael Neville Charles | Director | 17 Worfield Street SW11 4RB London | British | 62400200001 | ||||||||||
| BURGER, Alec Stanley | Director | 2 Adelaide Road KT12 1NA Walton On Thames Surrey | Us Citizen | 106681240001 | ||||||||||
| CASEY, Shay Andrew | Director | Ground Floor 69 Radipole Road SW6 5DN London | Irish | 90824990001 | ||||||||||
| DAVIES, Simon David Austin | Director | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building England | United Kingdom | British | 197508390001 | |||||||||
| DAVIES, Simon David Austin | Director | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England | United Kingdom | British | 197508390001 | |||||||||
| DEL BEATO, Ilaria Jane | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 93124450002 | |||||||||
| DEL BEATO, Ilaria Jane | Director | 42 Deveraux Road Battersea SW11 6JS London | British | 93124450001 | ||||||||||
| GATISS, Ian William | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | England | British | 95094220003 | |||||||||
| GATISS, Ian William | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | England | British | 95094220003 | |||||||||
| HARRIS, Neil Jason | Director | Pattison Lane Woolstone MK15 0AU Milton Keynes 11 Buckinghamshire | England | British | 94095660004 | |||||||||
| JACOBS, Philip | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 98827150004 | |||||||||
| JACOBS, Philip | Director | 8 Spring Grove W4 3NH London | United Kingdom | British | 98827150004 | |||||||||
| JEVNE, Anne | Director | Flat 8 70 Ironmonger Row EC1V 3QR London | Norwegian | 106807190001 | ||||||||||
| KATAKY, Gemma Nandita | Director | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building England | England | British | 180952110001 | |||||||||
| MANCHANDA, Anupam | Director | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England | United Kingdom | Indian | 196338510001 | |||||||||
| MARFLEET, Thomas | Director | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 139855250001 | |||||||||
| MARQUIS, Raymond Annel | Director | St James' Square SW1Y 4LB London 12 United Kingdom | England | British | 243770520001 | |||||||||
| MCCLURE, David Robert | Director | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England | England | British | 136660580003 | |||||||||
| MCKIE, Gordon Robert | Director | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England | England | British | 155757550001 | |||||||||
| PEARSON, William James | Director | Graham Road Wimbledon SW19 3SL London 171 | United Kingdom | British | 133539850001 | |||||||||
| ROWAN, Michael G | Director | 24 Weybridge Park KT13 8SQ Weybridge Surrey | American | 116087380002 | ||||||||||
| SAUL, Christopher Francis Irving | Director | 11 Chepstow Villas W11 3EE London | United Kingdom | British | 106157160001 | |||||||||
| SINGER, Joshua David | Director | Flat 12a Salisbury Court Salisbury Avenue N3 3AH London | United Kingdom | British | 82881130001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Group L.P | 26 jul 2019 | Park Avenue NY 10154 New York 345 United States | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
| Mr Stephen Allen Schwarzman | 30 oct 2018 | 345 Park Avenue NY 10154 New York The Blackstone Group L.P United States | Sí | ||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 13 jul 2016 | 30 oct 2018 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene KENSINGTON UK REAL ESTATE TRADING LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 15 jul 2015 Entregado el 21 jul 2015 | Pendiente | ||
Breve descripción Block C1 clarence dock chadwick street leeds t/no.WYK854303 and land on the north west side of bessemer road welwyn garden city t/no.HD413319. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0