GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05513232 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 05 abr 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Richard Allen como director el 30 sept 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 05 abr 2011 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr John Richard Allen el 06 jun 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark Samuel Wilton Lee el 01 jun 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 05 abr 2010 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 jun 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 30 páginas | MA | ||||||||||
Cambio de constitución por acto legislativo | 2 páginas | CC05 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Povall como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Wilks como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Nicholson como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Bunbury como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Euan Anstruther Gough Calthorpe como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Martin Brennan Woolhouse como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Lee como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Samuel Wilton Lee como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 05 abr 2009 | 14 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 5 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOLHOUSE, Martin Brennan | Secretario | Howards Meadow Kings Cliffe PE8 6YJ Peterborough 7 Northamptonshire England | 146450850001 | |||||||
| LEE, Mark Samuel Wilton | Director | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands | England | British | 54866930002 | |||||
| LEE, Mark Samuel Wilton | Secretario | Chadwick End Farm Oldwich Lane West Chadwick End B93 0BH Solihull West Midlands | British | 54866930001 | ||||||
| READMAN, Alison Mary | Secretario | 12 Prince Rupert's Way WS13 7ER Lichfield | British | 69382380002 | ||||||
| SMITH, Grace Mclean | Secretario | 3 David House 43 Station Road DA15 7DD Sidcup Kent | British | 7736120003 | ||||||
| ACI SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 2nd Floor 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900027740001 | |||||||
| ALLEN, John Richard | Director | 76 Hagley Road Edgbaston B16 8LU Birmingham West Midlands | England | British | 71282600003 | |||||
| ANSTRUTHER -GOUGH -CALTHORPE BT, Euan Hamilton, Sir | Director | Elvetham Farm House Home Farm Road RG27 8AN Hook Hampshire | Uk | British | 194595910001 | |||||
| BUNBURY, Michael William, Sir | Director | Flat 3 19 Redcliffe Square SW10 9LA London | England | British | 70449390001 | |||||
| MAHONEY, Patrick Edward | Director | 131 Cornwall Road HA4 6AH Ruislip Manor Middlesex | British | 1622710004 | ||||||
| NICHOLSON, Charles Christian, Sir | Director | Turners Green Farm Elvetham RG27 8BE Hook Hampshire | England | British | 43226700001 | |||||
| PICK, Graham John | Director | Hellier Drive Wombourne WV5 8AH Wolverhampton 3 Staffordshire | England | British | 139309010001 | |||||
| POVALL, David Edward | Director | St. Peters Road Harborne B17 0AU Birmingham 45 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 111052510002 | |||||
| WILKS, William Henry George | Director | 22 Cranmer Court Sloane Avenue SW3 3HN London | United Kingdom | British | 109579700001 | |||||
| ACI DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 2nd Floor 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900027730001 |
¿Tiene GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creado el 23 ene 2009 Entregado el 28 ene 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción L/H property k/a harborne court 67-69 harborne road edgbaston birmingham t/no. WM172642 and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH june 2002 and | Creado el 17 sept 2007 Entregado el 02 oct 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 04 abr 2006 Entregado el 20 abr 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The l/h property k/a harborne court 67/69 harborne road edgbaston birmingham t/n WM172642. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2002 and | Creado el 06 ene 2006 Entregado el 12 ene 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/2002 | Creado el 29 nov 2005 Entregado el 13 dic 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0