GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED

GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05513232
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta05 abr 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de John Richard Allen como director el 30 sept 2012

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 jun 2012

    Estado de capital el 06 jun 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 05 abr 2011

    16 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr John Richard Allen el 06 jun 2011

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Mark Samuel Wilton Lee el 01 jun 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 05 abr 2010

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Memorándum y Estatutos

    30 páginasMA

    Cambio de constitución por acto legislativo

    2 páginasCC05

    Cese del nombramiento de David Povall como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de William Wilks como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Charles Nicholson como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Bunbury como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Euan Anstruther Gough Calthorpe como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Martin Brennan Woolhouse como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Mark Lee como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Mark Samuel Wilton Lee como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 05 abr 2009

    14 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WOOLHOUSE, Martin Brennan
    Howards Meadow
    Kings Cliffe
    PE8 6YJ Peterborough
    7
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Howards Meadow
    Kings Cliffe
    PE8 6YJ Peterborough
    7
    Northamptonshire
    England
    146450850001
    LEE, Mark Samuel Wilton
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    Director
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish54866930002
    LEE, Mark Samuel Wilton
    Chadwick End Farm Oldwich Lane West
    Chadwick End
    B93 0BH Solihull
    West Midlands
    Secretario
    Chadwick End Farm Oldwich Lane West
    Chadwick End
    B93 0BH Solihull
    West Midlands
    British54866930001
    READMAN, Alison Mary
    12 Prince Rupert's Way
    WS13 7ER Lichfield
    Secretario
    12 Prince Rupert's Way
    WS13 7ER Lichfield
    British69382380002
    SMITH, Grace Mclean
    3 David House
    43 Station Road
    DA15 7DD Sidcup
    Kent
    Secretario
    3 David House
    43 Station Road
    DA15 7DD Sidcup
    Kent
    British7736120003
    ACI SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Secretario designado corporativo
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027740001
    ALLEN, John Richard
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    Director
    76 Hagley Road
    Edgbaston
    B16 8LU Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish71282600003
    ANSTRUTHER -GOUGH -CALTHORPE BT, Euan Hamilton, Sir
    Elvetham Farm House
    Home Farm Road
    RG27 8AN Hook
    Hampshire
    Director
    Elvetham Farm House
    Home Farm Road
    RG27 8AN Hook
    Hampshire
    UkBritish194595910001
    BUNBURY, Michael William, Sir
    Flat 3
    19 Redcliffe Square
    SW10 9LA London
    Director
    Flat 3
    19 Redcliffe Square
    SW10 9LA London
    EnglandBritish70449390001
    MAHONEY, Patrick Edward
    131 Cornwall Road
    HA4 6AH Ruislip Manor
    Middlesex
    Director
    131 Cornwall Road
    HA4 6AH Ruislip Manor
    Middlesex
    British1622710004
    NICHOLSON, Charles Christian, Sir
    Turners Green Farm
    Elvetham
    RG27 8BE Hook
    Hampshire
    Director
    Turners Green Farm
    Elvetham
    RG27 8BE Hook
    Hampshire
    EnglandBritish43226700001
    PICK, Graham John
    Hellier Drive
    Wombourne
    WV5 8AH Wolverhampton
    3
    Staffordshire
    Director
    Hellier Drive
    Wombourne
    WV5 8AH Wolverhampton
    3
    Staffordshire
    EnglandBritish139309010001
    POVALL, David Edward
    St. Peters Road
    Harborne
    B17 0AU Birmingham
    45
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    St. Peters Road
    Harborne
    B17 0AU Birmingham
    45
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish111052510002
    WILKS, William Henry George
    22 Cranmer Court
    Sloane Avenue
    SW3 3HN London
    Director
    22 Cranmer Court
    Sloane Avenue
    SW3 3HN London
    United KingdomBritish109579700001
    ACI DIRECTORS LIMITED
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Director designado corporativo
    2nd Floor
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900027730001

    ¿Tiene GREENBROOK PROPERTIES (EDGBASTON) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 23 ene 2009
    Entregado el 28 ene 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    L/H property k/a harborne court 67-69 harborne road edgbaston birmingham t/no. WM172642 and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge the property assets and rights of the company.
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 28 ene 2009Registro de un cargo (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH june 2002 and
    Creado el 17 sept 2007
    Entregado el 02 oct 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 02 oct 2007Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 04 abr 2006
    Entregado el 20 abr 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The l/h property k/a harborne court 67/69 harborne road edgbaston birmingham t/n WM172642. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC T/a Yorkshire Bank
    Transacciones
    • 20 abr 2006Registro de un cargo (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2002 and
    Creado el 06 ene 2006
    Entregado el 12 ene 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ene 2006Registro de un cargo (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/2002
    Creado el 29 nov 2005
    Entregado el 13 dic 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 dic 2005Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0