NUCLEUS FINANCIAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | NUCLEUS FINANCIAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05522098 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NUCLEUS FINANCIAL LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
- Administración de mercados financieros (66110) / Actividades financieras y de seguros
- Actividades auxiliares a la intermediación financiera n.c.o.p. (66190) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra NUCLEUS FINANCIAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | Suite B & C, First Floor Milford House 43-55 Milford Street SP1 2BP Salisbury United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NUCLEUS FINANCIAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NUCLEUS FINANCIAL PLC | 04 ene 2022 | 04 ene 2022 |
| NUCLEUS FINANCIAL GROUP PLC | 06 jul 2018 | 06 jul 2018 |
| MM&S (4094) LIMITED | 29 jul 2005 | 29 jul 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NUCLEUS FINANCIAL LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NUCLEUS FINANCIAL LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 28 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 12 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 28 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NUCLEUS FINANCIAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Helen Mary Wakeford como secretario el 04 feb 2026 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Louis Petherick como secretario el 04 feb 2026 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Louis Petherick como secretario el 15 dic 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Alice Sian Rhiannon Dixie como secretario el 15 dic 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 35 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Richard Alexander Rowney el 23 ene 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Miss Alice Sian Rhiannon Dixie como secretario el 01 feb 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Michelle Bruce como secretario el 01 feb 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Suites B& C, First Floor Milford House 43-55 Milford Street Salisbury Wiltshire SP1 2BP United Kingdom a Suite B & C, First Floor Milford House 43-55 Milford Street Salisbury SP1 2BP el 31 ene 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Dunn's House St. Paul's Road Salisbury Wiltshire SP2 7BF United Kingdom a Suites B& C, First Floor Milford House 43-55 Milford Street Salisbury Wiltshire SP1 2BP el 23 ene 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 35 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Michael Robert Regan el 12 sept 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Michael Robert Regan el 03 jul 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 57 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Kathryn Elizabeth Purves como director el 19 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Arthur Mark Dearsley como director el 11 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de David Victor Paige como director el 02 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Owen Henry Wilson como director el 21 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de William De Bretton Priestley como director el 21 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Michael Robert Regan como director el 12 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart James Geard como director el 12 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de NUCLEUS FINANCIAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKEFORD, Helen Mary | Secretario | Milford House 43-55 Milford Street SP1 2BP Salisbury Suite B & C, First Floor United Kingdom | 345897610001 | |||||||
| REGAN, Michael Robert | Director | Milford House 43-55 Milford Street SP1 2BP Salisbury Suite B & C, First Floor United Kingdom | England | British | 318039950001 | |||||
| ROWNEY, Richard Alexander | Director | Milford House 43-55 Milford Street SP1 2BP Salisbury Suite B & C, First Floor United Kingdom | England | British | 123319120003 | |||||
| BRUCE, Michelle | Secretario | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh Greenside United Kingdom | 271553220001 | |||||||
| DIXIE, Alice Sian Rhiannon | Secretario | Milford House 43-55 Milford Street SP1 2BP Salisbury Suite B & C, First Floor United Kingdom | 332053440001 | |||||||
| MATHIESON, Aileen Jeanette | Secretario | London Wall EC2Y 5AB London One United Kingdom | 171570840001 | |||||||
| MATHIESON, Aileen Janette | Secretario | Thistle Street Lane North West EH2 1BY Edinburgh 22 Scotland | 160488670001 | |||||||
| MCNEIL, John | Secretario | Thistle Street Lane North West EH2 1EA Edinburgh 22 United Kingdom | 169027700001 | |||||||
| MEGAW, Nicola | Secretario | St Georges Business Park 207 Brooklands Road KT13 0TS Weybridge Elder House Surrey England | 177968570001 | |||||||
| PETHERICK, Louis | Secretario | Milford House 43-55 Milford Street SP1 2BP Salisbury Suite B & C, First Floor United Kingdom | 344054040001 | |||||||
| PROWSE, Leanne | Secretario | Thistle Street Lane North West EH2 1BY Edinburgh 22 Scotland | British | 154279340001 | ||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario designado corporativo | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario designado corporativo | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||
| BLOCH, Andrew Charles Danby | Director | London Wall EC2Y 5AB London One United Kingdom | United Kingdom | British | 26820090001 | |||||
| BRADSHAW, Paul Richard | Director | Thistle Street Lane North West EH2 1BY Edinburgh 22 Scotland | United Kingdom | British | 47181430001 | |||||
| CHRISTODOULOU, Nicholas Theodoro | Director | 4075 Valley Road Hout Bay FOREIGN Cape Town 7872 South Africa | South African | 95584120001 | ||||||
| DEARSLEY, Arthur Mark | Director | St Paul's Road SP2 7BF Salisbury Dunn's House United Kingdom | United Kingdom | British | 241071460001 | |||||
| DUNLEY-OWEN, Tracy | Director | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh Greenside United Kingdom | England | British,South African | 191223240001 | |||||
| FERGUSON, David Ritchie | Director | St Georges Business Park 207 Brooklands Road KT13 0TS Weybridge Elder House Surrey England | United Kingdom | British | 65396400007 | |||||
| GEARD, Stuart James | Director | St. Paul's Road SP2 7BF Salisbury Dunn's House Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British,South African | 113691230008 | |||||
| GIBSON, Jeremy Paul | Director | St Georges Business Park 207 Brooklands Road KT13 0TS Weybridge Elder House Surrey England | England | British | 161139510001 | |||||
| HASSALL, Margaret Grace | Director | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh Greenside United Kingdom | Scotland | British | 185329760001 | |||||
| HOWITT, Neil Julian Albric | Director | 2 Coronation Road Prestbury GL52 3DA Cheltenham Gloucestershire | British | 52131300001 | ||||||
| LEVIN, John Anthony | Director | St Georges Business Park 207 Brooklands Road KT13 0TS Weybridge Elder House Surrey England | England | British | 51113530005 | |||||
| MARTIN, Philip Torbet | Director | 1 Nelson Street EH3 6LF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 65032200002 | |||||
| MATHIESON, Aileen Janette | Director | Thistle Street Lane North West EH2 1BY Edinburgh 22 Scotland | Scotland | British | 150442740001 | |||||
| MOORE, John Clark | Director | London Wall EC2Y 5AB London One United Kingdom | Scotland | British | 129498760001 | |||||
| OWEN, Robert Richardson | Director | Thistle Street Lane South West EH2 1EW Edinburgh 39 Scotland | England | British | 86108600001 | |||||
| PAIGE, David Victor | Director | St Paul's Road SP2 7BF Salisbury Dunn's House United Kingdom | United Kingdom | British | 253681710002 | |||||
| POLIN, Jonathan Charles | Director | St Georges Business Park 207 Brooklands Road KT13 0TS Weybridge Elder House Surrey England | Scotland | British | 97840060003 | |||||
| PRIESTLEY, William De Bretton | Director | St Paul's Road SP2 7BF Salisbury Dunn's House United Kingdom | United Kingdom | British | 153564530006 | |||||
| PURVES, Kathryn Elizabeth | Director | St Paul's Road SP2 7BF Salisbury Dunn's House United Kingdom | United Kingdom | British | 98017050003 | |||||
| SAMUELS, James Anthony Angus | Director | St Georges Business Park 207 Brooklands Road KT13 0TS Weybridge Elder House Surrey England | England | British | 66307920004 | |||||
| SEDDON, Michael David | Director | London Wall EC2Y 5AB London One | England | British | 186956490001 | |||||
| TAGLIABUE, Alfio | Director | St Georges Business Park 207 Brooklands Road KT13 0TS Weybridge Elder House Surrey England | United Kingdom | Italian | 76352220004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NUCLEUS FINANCIAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hay Holdings Limited | 20 ago 2021 | St. Pauls Road SP2 7BF Salisbury Dunn's House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mrs Nicola Clare Megaw | 08 may 2018 | London Wall EC2Y 5AB London One | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Sanlam Uk Limited | 06 abr 2016 | Lewin's Mead BS1 2NH Bristol St Bartholomews House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Nucleus Ifa Company Limited | 06 abr 2016 | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh Greenside United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0