BILLING ASSETS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BILLING ASSETS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | En administración |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05546272 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BILLING ASSETS LIMITED?
- Gestión financiera (70221) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra BILLING ASSETS LIMITED?
Dirección de la sede social | 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BILLING ASSETS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
GW 907 LIMITED | 25 ago 2005 | 25 ago 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BILLING ASSETS LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2023 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2023 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ene 2022 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BILLING ASSETS LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 ago 2023 |
Próxima declaración de confirmación vence | 08 sept 2023 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 ago 2022 |
Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BILLING ASSETS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Informe de progreso del administrador | 40 páginas | AM10 | ||
Informe de progreso del administrador | 76 páginas | AM10 | ||
Aviso de extensión del período de la administración | 3 páginas | AM19 | ||
Cese del nombramiento de Robert Lee Jack Bull como director el 01 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Informe de progreso del administrador | 85 páginas | AM10 | ||
Notificación de la aprobación presunta de las propuestas | 3 páginas | AM06 | ||
Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA | 9 páginas | AM02 | ||
Declaración de la propuesta del administrador | 165 páginas | AM03 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Royale House 1550 Parkway Whiteley Fareham PO15 7AG England a 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB el 21 jul 2023 | 2 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de un administrador | páginas | AM01 | ||
Nombramiento de un administrador | 3 páginas | AM01 | ||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 ene 2023 au 31 mar 2023 | 1 páginas | AA01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2022 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga 055462720007, creada el 14 jul 2022 | 62 páginas | MR01 | ||
Registro de la carga 055462720006, creada el 01 mar 2022 | 55 páginas | MR01 | ||
Cambio de datos del director Mr Jason Mark Williams el 01 dic 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Robert Lee Jack Bull el 01 nov 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2021 | 19 páginas | AA | ||
Registro de la carga 055462720005, creada el 28 sept 2021 | 49 páginas | MR01 | ||
Cancelación total de la carga 055462720004 | 1 páginas | MR04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de South Lakeland House Main a6 Yealand Redmayne Carnforth Lancashire LA5 9RN a Royale House 1550 Parkway Whiteley Fareham PO15 7AG el 30 sept 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cessation de John Charles Morphet en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 sept 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Royale Resorts 1 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 sept 2021 | 2 páginas | PSC02 | ||
Nombramiento de Mr Jason Mark Williams como director el 28 sept 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de BILLING ASSETS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS, Jason Mark | Director | Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester 11th Floor | England | British | Director | 194866870003 | ||||
DODD, Nicholas | Secretario | Apartment 9 Worsley Mill Castlefield M15 4LG Manchester | British | Company Director | 110921000001 | |||||
ROSSITER, Paul | Secretario | Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth South Lakeland House Lancashire United Kingdom | 185797090001 | |||||||
ROWORTH, Shena Marie | Secretario | 9 Lower Road Milton Malsor NN7 3AW Northampton Northamptonshire | British | Director | 92767290002 | |||||
ROYLE, Christopher Anthony | Secretario | 186 Runcorn Road Moore WA4 6SY Warrington Cheshire | British | 112530050001 | ||||||
GW SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 93128710001 | |||||||
ANGELIDES, Peter | Director | South Lakeland House Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth Lancashire | England | British | Caravan Park Manager | 164893850001 | ||||
BULL, Robert Lee Jack | Director | Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester 11th Floor | England | British | Director | 240346910002 | ||||
CROWE, Andrew | Director | South Lakeland House Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth Lancashire | United Kingdom | British | Sales Manager | 151961870001 | ||||
DAWSON, Russell Michael | Director | Vernon Road FY8 2RQ Lytham St. Annes 14 Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 140774020001 | ||||
DODD, Nicholas | Director | Apartment 9 Worsley Mill Castlefield M15 4LG Manchester | British | Company Director | 110921000001 | |||||
FOX, Anthony Maxwell | Director | South Lakeland House Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth Lancashire | United Kingdom | British | Director | 46490780001 | ||||
HAMILTON, Iain Duncan Hamish | Director | 5 Tomore Close Heapey PR9 9BP Chorley Lancashire | British | Chartered Accountant | 127877720001 | |||||
HILL, Malcolm Richard | Director | Breccia Gardens WA9 1SB St Helens 70 Merseyside | England | British | Human Resources Director | 134064930001 | ||||
HODGSON, Graham Robert | Director | 5 Mount Avenue Bare LA4 6DJ Morecambe Lancashire | British | Company Director | 26693690002 | |||||
MACKANESS, Paul | Director | The Old Dairy Rookery Lane Stoke Bruerne NN12 7SJ Towcester Northamptonshire | British | Director | 110129270001 | |||||
MACKANESS, Sam | Director | Preston Deanery Hall Preston Deanery NN7 2DX Northampton Northamptonshire | England | British | Director | 7612240001 | ||||
MORPHET, John Charles | Director | South Lakeland House Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth Lancashire | United Kingdom | British | Managing Director | 212636330002 | ||||
MORPHET, John Charles | Director | Hallmore House Hale LA7 7BP Milnthorpe Cumbria | England | British | Company Secretary | 77451570001 | ||||
MORPHET, Victoria Helen | Director | Hall More House Hale LA7 7BP Milnthorpe Cumbria | British | Company Director | 98873520001 | |||||
ROSSITER, Paul | Director | South Lakeland House Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth Lancashire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 68174110001 | ||||
ROWORTH, Shena Marie | Director | 9 Lower Road Milton Malsor NN7 3AW Northampton Northamptonshire | British | Director | 92767290002 | |||||
WALKER, Gordon Alexander | Director | South Lakeland House Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth Lancashire | United Kingdom | British | Operations Director | 299561840001 | ||||
WHITE, Trevor James | Director | South Lakeland House Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth Lancashire | England | British | Marketing Manager | 148253110001 | ||||
WIMPENNY, Nigel Byron | Director | South Lakeland House Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth Lancashire | England | British | Company Director | 292182860001 | ||||
GW INCORPORATIONS LIMITED | Director corporativo | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 68279000003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BILLING ASSETS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royale Resorts 1 Limited | 28 sept 2021 | 1550 Parkway Whiteley PO15 7AG Fareham Royale House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr John Charles Morphet | 06 abr 2016 | South Lakeland House Main A6 Yealand Redmayne LA5 9RN Carnforth Lancashire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: Isle Of Man | |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene BILLING ASSETS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 14 jul 2022 Entregado el 14 jul 2022 | Pendiente | ||
Breve descripción All assets rights and liabilities of the chargor as outlined in the instrument. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 01 mar 2022 Entregado el 02 mar 2022 | Pendiente | ||
Breve descripción All assets rights and liabilities of the chargor. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 28 sept 2021 Entregado el 04 oct 2021 | Pendiente | ||
Breve descripción All assets rights and liabilities of the chargor. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 30 jun 2015 Entregado el 03 jul 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 19 sept 2014 Entregado el 29 sept 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 12 jul 2013 Entregado el 18 jul 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A security agreement | Creado el 17 mar 2006 Entregado el 03 abr 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Land investments plant and machinery credit balance insurances other contracts and intellectual property and by way of floating charge all assets not otherwise effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene BILLING ASSETS LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| En administración |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0