LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED

LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05586358
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    • Procesamiento y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (10200) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FINDUS GROUP LIMITED28 may 200928 may 2009
    FOODVEST LIMITED08 nov 200508 nov 2005
    BROOMCO (3920) LIMITED07 oct 200507 oct 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Segunda presentación de un estado de capital tras una asignación de acciones el 03 jul 2019

    • Capital: GBP 24,312.22
    18 páginasRP04SH01

    Nombramiento de Mr John Philip Madden como director el 08 nov 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de William John Showalter como director el 11 nov 2019

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW a Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ el 08 nov 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 07 oct 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    41 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resoluciones

    Conflicts of interest 03/07/2019
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    6 páginasAA

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 03 jul 2019

    • Capital: GBP 24,312.22
    11 páginasSH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    27 nov 2019Clarification A second filed SH01 was registered on 27/11/2019.

    Cancelación total de la carga 055863580006

    4 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 07 oct 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    7 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Wilkin Chapman Company Secretarial Services Ltd el 02 ene 2017

    1 páginasCH04

    Declaración de confirmación presentada el 07 oct 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016

    16 páginasAA

    Memorándum y Estatutos

    38 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cese del nombramiento de Karen Jeanette Noakes como director el 01 feb 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 07 oct 2016 con actualizaciones

    13 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2015

    16 páginasAA

    Nombramiento de Karen Jeanette Noakes como director el 29 feb 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Guy Nicholas Anthony Faller como director el 29 feb 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Frank Parker como director el 31 ene 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secretario designado corporativo
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2249348
    900013350001
    MADDEN, John Philip
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandBritish264245380001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Secretario
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    British84487230001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Director
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    CAMPBELL, Christopher
    74 Coleherne Court
    Little Boltons
    SW5 0EF London
    Director
    74 Coleherne Court
    Little Boltons
    SW5 0EF London
    American109921890001
    CANE, James Robert
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    Director
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    United KingdomBritish104635350001
    FALLER, Guy Nicholas Anthony
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Director
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish108529830002
    FITZPATRICK, Seamus Philip
    Flat 1
    1 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    Director
    Flat 1
    1 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    United KingdomIrish65991000003
    FORBES, Hamish Drummond
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish66295550001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Director
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Strandvejen 399a
    Klampenborg
    2930
    Denmark
    Director
    Strandvejen 399a
    Klampenborg
    2930
    Denmark
    Danish78882450002
    JOHANSSON, Roger
    Kompassgatan 36
    FOREIGN Malmo
    211 17
    Sweden
    Director
    Kompassgatan 36
    FOREIGN Malmo
    211 17
    Sweden
    Swedish113571210001
    KARLSSON, Cecilia
    Vassarogatan 11
    Rydebaeck
    25733
    Sweden
    Director
    Vassarogatan 11
    Rydebaeck
    25733
    Sweden
    Swedish113571120001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Director
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LITTLE, Malcolm John
    Leylandii House
    3 Shipton Road
    YO30 5RE York
    North Yorkshire
    Director
    Leylandii House
    3 Shipton Road
    YO30 5RE York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish44199400002
    MILNER, David Richard
    Park House
    Holkham
    NR23 1RN Norfolk
    Director
    Park House
    Holkham
    NR23 1RN Norfolk
    United KingdomBritish150546560001
    NOAKES, Karen Jeanette
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Director
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish134379900001
    OLSSON, Jorgen
    Grontevaegen 3
    Helsingborg
    25285
    Sweden
    Director
    Grontevaegen 3
    Helsingborg
    25285
    Sweden
    Swedish113571020001
    PARKER, Christopher Frank
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Director
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish66681550001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Director
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    SHOWALTER, William John
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandAmerican178622380001
    SHURE, Randl Louis
    2045 Dogwood Lane
    IRISH Charlottesville
    Virginia 22901
    Usa
    Director
    2045 Dogwood Lane
    IRISH Charlottesville
    Virginia 22901
    Usa
    American94192640001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Director
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001
    DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610002
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06 abr 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalLaw Of England And Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06025321
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 02 nov 2015
    Entregado el 09 nov 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 09 nov 2015Registro de una carga (MR01)
    • 13 may 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 19 jul 2013
    Entregado el 25 jul 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch
    Transacciones
    • 25 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    • 14 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 23 oct 2008
    Entregado el 01 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 01 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 21 mar 2007
    Entregado el 31 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale the Security Agent
    Transacciones
    • 31 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 mar 2006
    Entregado el 25 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transacciones
    • 25 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 dic 2005
    Entregado el 17 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transacciones
    • 17 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0