LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05586358 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
- Procesamiento y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (10200) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby North East Lincolnshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FINDUS GROUP LIMITED | 28 may 2009 | 28 may 2009 |
| FOODVEST LIMITED | 08 nov 2005 | 08 nov 2005 |
| BROOMCO (3920) LIMITED | 07 oct 2005 | 07 oct 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||
Segunda presentación de un estado de capital tras una asignación de acciones el 03 jul 2019
| 18 páginas | RP04SH01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr John Philip Madden como director el 08 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de William John Showalter como director el 11 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW a Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ el 08 nov 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 oct 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 41 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 03 jul 2019
| 11 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 055863580006 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Wilkin Chapman Company Secretarial Services Ltd el 02 ene 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 oct 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 38 páginas | MA | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Karen Jeanette Noakes como director el 01 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 oct 2016 con actualizaciones | 13 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2015 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Karen Jeanette Noakes como director el 29 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Guy Nicholas Anthony Faller como director el 29 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Frank Parker como director el 31 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 900013350001 | ||||||||||
| MADDEN, John Philip | Director | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Wilkin Chapman Llp, Cartergate House North East Lincolnshire England | England | British | 264245380001 | |||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Secretario | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | British | 84487230001 | ||||||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 | |||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Director | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| CAMPBELL, Christopher | Director | 74 Coleherne Court Little Boltons SW5 0EF London | American | 109921890001 | ||||||||||
| CANE, James Robert | Director | Chapel House Brigg Road LN7 6PQ South Kelsey Lincolnshire | United Kingdom | British | 104635350001 | |||||||||
| FALLER, Guy Nicholas Anthony | Director | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 108529830002 | |||||||||
| FITZPATRICK, Seamus Philip | Director | Flat 1 1 Onslow Gardens SW7 3LX London | United Kingdom | Irish | 65991000003 | |||||||||
| FORBES, Hamish Drummond | Director | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire United Kingdom | England | British | 66295550001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan | Director | Hawerby Hall DN36 5PX Hawerby Cum Beesby Lincolnshire | United Kingdom | British | 58713750002 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Director | Strandvejen 399a Klampenborg 2930 Denmark | Danish | 78882450002 | ||||||||||
| JOHANSSON, Roger | Director | Kompassgatan 36 FOREIGN Malmo 211 17 Sweden | Swedish | 113571210001 | ||||||||||
| KARLSSON, Cecilia | Director | Vassarogatan 11 Rydebaeck 25733 Sweden | Swedish | 113571120001 | ||||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Director | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LITTLE, Malcolm John | Director | Leylandii House 3 Shipton Road YO30 5RE York North Yorkshire | United Kingdom | British | 44199400002 | |||||||||
| MILNER, David Richard | Director | Park House Holkham NR23 1RN Norfolk | United Kingdom | British | 150546560001 | |||||||||
| NOAKES, Karen Jeanette | Director | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire | England | British | 134379900001 | |||||||||
| OLSSON, Jorgen | Director | Grontevaegen 3 Helsingborg 25285 Sweden | Swedish | 113571020001 | ||||||||||
| PARKER, Christopher Frank | Director | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 66681550001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Director | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| SHOWALTER, William John | Director | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Wilkin Chapman Llp, Cartergate House North East Lincolnshire England | England | American | 178622380001 | |||||||||
| SHURE, Randl Louis | Director | 2045 Dogwood Lane IRISH Charlottesville Virginia 22901 Usa | American | 94192640001 | ||||||||||
| WARD, Peter Selwyn | Director | 155 Eastgate LN11 8DB Louth Lincolnshire | United Kingdom | British | 33803400001 | |||||||||
| DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED | Director corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146610002 | |||||||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighthouse Ukco 3 Limited | 06 abr 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 02 nov 2015 Entregado el 09 nov 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 19 jul 2013 Entregado el 25 jul 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 oct 2008 Entregado el 01 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 mar 2007 Entregado el 31 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 16 mar 2006 Entregado el 25 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 dic 2005 Entregado el 17 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0