TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED

TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05593395
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2nd Floor, St James House The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GENER8 FINANCE LIMITED14 oct 200514 oct 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 may 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Estado de capital el 22 may 2023

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c 18/05/2023
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2022

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr James Matthew Arthur Roberts como secretario el 14 abr 2022

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jennifer Bodey como secretario el 14 abr 2022

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2021

    27 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Gener8 Finance Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 dic 2020

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Richard Ian Smith como director el 27 feb 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Edward John Rimmer como director el 22 feb 2021

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2020

    27 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 26 nov 2020

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Edward John Rimmer como director el 30 abr 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 may 2019

    25 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 1

    2 páginasMR04

    Registro de la carga 055933950003, creada el 16 abr 2019

    6 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROBERTS, James Matthew Arthur
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Secretario
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    295102770001
    RIMMER, Edward John
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Director
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    United KingdomBritishCompany Director67922850004
    ROBERTS, James Matthew Arthur
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Director
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    EnglandBritishDirector230810310001
    BODEY, Jennifer
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Secretario
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    247026940001
    CASE, Thomas Richard
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Secretario
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    233229490001
    RAVEN, Philip
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    Secretario
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    197613660001
    RICHARDS, Tracey Louise
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Secretario
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    BritishAccountant102918940002
    DMCS SECRETARIES LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Secretario corporativo
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    39259480001
    BUCKLEY, Peter Jonathan
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Director
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritishDirector142502720001
    COX, Michael Francis
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    Langwood House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    63-81 High Street
    WD3 1EQ Rickmansworth
    Langwood House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector54129020003
    INGOLDBY, Jillian
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector126822990001
    LONGHURST, Jeffrey Daniels
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Director
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritishDirector119069920001
    MATON, Timothy
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector72223280001
    OGILVY, Diarmid
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    BritishDirector131878810001
    RICHARDS, David Mark
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Director
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritishDirector126107150001
    RICHARDS, Tracey Louise
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    Director
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    United KingdomBritishDirector102918940002
    RIMMER, Edward John
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Director
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    United KingdomBritishDirector67922850004
    SCOTT, Simon Gregory Thomas
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    Director
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritishDirector58936390002
    SMITH, Richard Ian
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    Director
    The Square,
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor, St James House
    England
    WalesBritishDirector105152600001
    STOKES, Paul Andrew
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    Director
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g Innovation Drive
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritishDirector161361360003
    SUMNER, Brian Richard
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    BritishDirector59440390001
    WATERS, Jonathan Richard
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    The White Barn
    Manor Farm Manor Road
    OX12 8NE Wantage
    18
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector114098810001
    WIGNALL, Mark Steven
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    Director
    Innovation Drive
    Milton Park
    OX14 4RX Abingdon
    68g
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritishDirector18462760001
    DMCS DIRECTORS LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Director corporativo
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    39259470001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Time Commercial Finance Limited
    St James House, The Square
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor
    England
    06 abr 2016
    St James House, The Square
    Lower Bristol Road
    BA2 3BH Bath
    2nd Floor
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro09393231
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene TIME INVOICE FINANCE (SOUTH) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 16 abr 2019
    Entregado el 25 abr 2019
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 25 abr 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 01 mar 2019
    Entregado el 08 mar 2019
    Pendiente
    Breve descripción
    N/A.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 08 mar 2019Registro de una carga (MR01)
    All assets debenture
    Creado el 01 may 2008
    Entregado el 10 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 10 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0