CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED

CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASTLEGATE HOUSE GP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05616415
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Castlegate House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO. 18) LIMITED08 nov 200508 nov 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    15 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2020

    20 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2019

    21 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2018

    20 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2017

    9 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2016

    9 páginas4.68

    Cese del nombramiento de Philip Littlehales como director el 25 feb 2015

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Tyburn Lane Private Equity 43-44 Albemarle Street London W1S 4JJ a Castlegate House 36 Castle Street Hertford Hertfordshire SG14 1HH el 19 feb 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    5 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 05 feb 2015

    LRESEX

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 nov 2014

    Estado de capital el 18 nov 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 nov 2013

    Estado de capital el 11 nov 2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Nombramiento de Mr Robert Savill como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Philippa Scobie como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Thomas Walsh como director

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Mrs Philippa Scobie el 10 oct 2012

    1 páginasCH03

    Nombramiento de Mrs Philippa Scobie como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de David Morgan como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SAVILL, Robert
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Secretario
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    176203500001
    DALY, John Francis
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Director
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish78960760003
    O'HARA, Patrick
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Director
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    EnglandIrish82724260003
    PARKER, Gordon
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Director
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    EnglandIrish85330570006
    WALSH, Thomas Gerard
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Director
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    EnglandIrish48520230001
    BULLENT, Gemma
    52a Cricketfield Road
    E5 8NS London
    Secretario
    52a Cricketfield Road
    E5 8NS London
    British99948940001
    DUNKLEY, Philippa
    Lamerton Lodge 228 Kew Road
    TW9 3JX Richmond
    Flat 1
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Lamerton Lodge 228 Kew Road
    TW9 3JX Richmond
    Flat 1
    Surrey
    United Kingdom
    Other124641320002
    MORGAN, David Richard
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Secretario
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    147340710001
    PARKER, Gordon
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    Secretario
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    Irish85330570001
    SCOBIE, Philippa
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Secretario
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    167237380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    LITTLEHALES, Philip
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Director
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish109822600001
    MURRAY, David
    Kinsale
    90 Lower Ham Road
    KT2 5BB Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    Kinsale
    90 Lower Ham Road
    KT2 5BB Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandIrish100446830001
    WALSH, Thomas Paschal
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Director
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    United KingdomIrish130192900001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental debenture
    Creado el 21 abr 2006
    Entregado el 03 may 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors or any of them to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All estates or interests in the redcastle property being the f/h property k/a 20-22 haymarket and 4-12 dixon lane, sheffield, south yorkshire t/no SYK440529, and all fixtures and buildings thereon and assigns all rental income and all insurances relating to the redcastle property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Westdeutsche Immobilienbank, as Arranger, Agent and Security Trustee for the Banks
    Transacciones
    • 03 may 2006Registro de un cargo (395)
    Supplemental debenture
    Creado el 21 abr 2006
    Entregado el 03 may 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors or any of them to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All estates or interests in the redcastle property being the f/h property k/a 20-22 haymarket and 4-12 dixon lane, sheffield, south yorkshire t/no SYK440529, and all fixtures and buildings thereon and assigns all rental income and all insurances relating to the redcastle property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Westdeutsche Immobilienbank, as Arranger, Agent and Security Trustee for the Banks
    Transacciones
    • 03 may 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 20 ene 2006
    Entregado el 06 feb 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The property known as castle gate house 12/18 haymarket and 8/12 dixon lane sheffield south yorkshire, f/h t/n's YK14962 YK21945 and l/h t/n YK28839,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Westdeutsche Immobilienbank Acting Through Its London Branch as Agent Arranger and Securitytrustee
    Transacciones
    • 06 feb 2006Registro de un cargo (395)
    Subordination deed
    Creado el 20 ene 2006
    Entregado el 06 feb 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to any of the senior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All and every benefit payment value distribution or security in cash or in kind of, or on account of, any of the subordinated liabilities or any part thereof,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Westdeutsche Immobilienbank Acting Through Its London Branch as Agent Arranger and Securitytrustee
    Transacciones
    • 06 feb 2006Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene CASTLEGATE HOUSE GP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 ene 2021Fecha de disolución
    05 feb 2015Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard William James Long
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford
    Profesional
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0