BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05647966 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD?
| Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BRITISH LAND SUPERSTORES (FUNDING) LIMITED | 20 dic 2005 | 20 dic 2005 |
| STOREBELL LIMITED | 07 dic 2005 | 07 dic 2005 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr James Michael Pinkstone el 07 ago 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Hursh Shah como director el 03 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de James Watson como director el 03 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de James Andrew Honeyman como director el 03 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de David William Pilbeam como director el 03 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Bruce Richardson como director el 03 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Philip Gallier como director el 03 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||
Nombramiento de Mr Philip Gallier como director el 03 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Martyn Stephen Burke como director el 03 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Dean Clegg como director el 26 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr David William Pilbeam el 26 nov 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr David William Pilbeam como director el 26 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 21 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de David Clifford Wheeler como director el 14 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Bruce Richardson como director el 14 jun 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Sarah Nelson como director el 14 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr David Clifford Wheeler como director el 14 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 dic 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| COWEN, Geraint Jamie | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 141040000003 | |||||||||
| PINKSTONE, James Michael | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 241498640002 | |||||||||
| EKPO, Ndiana | Secretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ATKINSON, William Stephen | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 174566650001 | |||||||||
| BAGULEY, Peter Jeffrey | Director | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | 175617500001 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Director | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||||||
| BELL-BROWN, Philip | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 119073370001 | |||||||||
| BIRCH, John Matthew | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 191027500001 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Director | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| BURKE, Martyn Stephen | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 152531940004 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| CLEGG, Dean | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 189632520001 | |||||||||
| COHEN, Carolina Alfred | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 248093020001 | |||||||||
| FLEMING, Richard Alexander | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 125990210002 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| FRANCIS, Luke Thomas | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 223122340001 | |||||||||
| GALLIER, Philip | Director | Rutherford Heights Rodney Road SE17 1AS London 805 United Kingdom | United Kingdom | British | 265528310001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| HONEYMAN, James Andrew | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 201179510001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEWIS, Bryan John | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 58257940003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Director | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||||||
| MOORE, Stephen Howard | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 185276290002 | |||||||||
| NELSON, Sarah | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 220620220001 | |||||||||
| O'LOAN, David Arthur | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 137230800001 | |||||||||
| PILBEAM, David William | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 265148550001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blssp Property Holdings Limited | 07 dic 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene BL SUPERSTORES (FUNDING) LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Borrower deed of charge | Creado el 28 feb 2006 Entregado el 09 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right title and interest and benefit in to and under the borrower documents all moneys standing to the credit of any account, book and other debts goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0