AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED

AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05661235
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED?

    • fabricación de productos farmacéuticos básicos (21100) / Industrias manufactureras
    • Investigación y desarrollo experimental en biotecnología (72110) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Aesica Formulation Development Limited Windmill Industrial Estate
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Northumberland
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    R5 PHARMACEUTICALS LIMITED14 ago 200614 ago 2006
    R5 LIMITED22 dic 200522 dic 2005

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 14 oct 2020

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    9 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 11/10/2020
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2020

    22 páginasAA

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Consort Medical Plc Breakspear Park Breakspear Way Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4TZ England a Aesica Formulation Development Limited Windmill Industrial Estate Shotton Lane Cramlington Northumberland NE23 3JL

    1 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de Suite B Breakspear Park Breakspear Way Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4TZ England a Aesica Formulation Development Limited Windmill Industrial Estate Shotton Lane Cramlington Northumberland NE23 3JL el 24 jul 2020

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Aesica Queenborough Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 abr 2020

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Mr Mark Royston Quick como director el 15 jun 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Leonard Jackson como secretario el 30 abr 2020

    1 páginasTM02

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2020 au 31 ene 2020

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Paul Andrew Hayes como director el 04 feb 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Martin Glenn como director el 04 feb 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Thomas Eldered como director el 04 feb 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Manja Hermina Elisabeth Maria Boerman como director el 30 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2019

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Andrew Leonard Jackson como secretario el 07 sept 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Paul Andrew Hayes como secretario el 07 sept 2018

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2018

    17 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ELDERED, Thomas Bengt
    Box 603
    101 32 Stockholm
    Recipharm Ab (Publ)
    Sweden
    Director
    Box 603
    101 32 Stockholm
    Recipharm Ab (Publ)
    Sweden
    SwedenSwedish266996040001
    QUICK, Mark Royston
    Windmill Industrial Estate
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Aesica Formulation Development Limited
    Northumberland
    England
    Director
    Windmill Industrial Estate
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Aesica Formulation Development Limited
    Northumberland
    England
    EnglandBritish124779290002
    CROCKER, Glenn, Dr
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Street
    NG1 1GF Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Street
    NG1 1GF Nottingham
    Nottinghamshire
    British90368460001
    HAYES, Paul Andrew
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Secretario
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    243809280001
    ILETT, John Edward
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Secretario
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    202401700001
    JACKSON, Andrew Leonard
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Secretario
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    250537540001
    NICHOLSON, Paul
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    England
    Secretario
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    England
    153169140001
    TUXFORD, Roy
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    United Kingdom
    Secretario
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    United Kingdom
    165813370001
    WARD, Iain Stuart
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Secretario
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    192881670001
    BOERMAN, Manja Hermina Elisabeth Maria, Dr
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Director
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutch232164260001
    COTTON, Richard John
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Director
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish170307480002
    CROCKER, Glenn, Dr
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Street
    NG1 1GF Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Street
    NG1 1GF Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish90368460001
    FAZACKERLEY, Richard Newman
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Director
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    EnglandBritish192867410001
    GLENN, Jonathan Martin
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Director
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish148251560003
    HARDY, Robert, Dr
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    England
    Director
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritish97702700002
    HAYES, Paul Andrew
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Director
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish160870900001
    HUNNEYBALL, Ian Michael, Professor
    c/o Evotec
    Milton Park
    Milton
    OX14 4SA Abingdon
    114
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Evotec
    Milton Park
    Milton
    OX14 4SA Abingdon
    114
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86789270001
    JONES, Nicholas Vaughan
    Q5, Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Aesica Pharmaceuticals,
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Director
    Q5, Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Aesica Pharmaceuticals,
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish163997380001
    JONES, Nicholas Vaughan
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Lane
    NG1 1GF Nottingham
    Director
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Lane
    NG1 1GF Nottingham
    United KingdomBritish163997380001
    JORDAN, David, Dr
    3 Leary Crescent
    Chicheley Park
    MK16 9GA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Director
    3 Leary Crescent
    Chicheley Park
    MK16 9GA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    EnglandBritish97712010001
    LAFFERTY, Ian William, Dr
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    Director
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    United KingdomIrish101027170002
    MCCONNELL, John Martin
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    Director
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    EnglandBritish153171460001
    MUIR, Ian Stuart
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Director
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish192862540001
    NICHOLSON, Paul
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    Director
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish248337880001
    TITLEY, Paul Charlton
    West View
    The Heads
    CA12 5ES Keswick
    Cumbria
    Director
    West View
    The Heads
    CA12 5ES Keswick
    Cumbria
    United KingdomBritish107189380001
    WARD, Iain Stuart
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Director
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    EnglandBritish192908500001
    WATERHOUSE, Janette, Dr
    16 Highfield Close
    SK3 8UB Stockport
    Cheshire
    Director
    16 Highfield Close
    SK3 8UB Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish117811100001
    WILDING, Ian, Dr
    10 Glebe Street
    NG11 6JS Beeston
    Nottinghamshire
    Director
    10 Glebe Street
    NG11 6JS Beeston
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish111933510001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    North Road
    ME11 5EL Queenborough
    Aesica Queenborough Limited
    Kent
    England
    06 abr 2016
    North Road
    ME11 5EL Queenborough
    Aesica Queenborough Limited
    Kent
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro6350087
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 21 mar 2014
    Entregado el 25 mar 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Tm numbers 2505093 and 2548332. notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transacciones
    • 25 mar 2014Registro de una carga (MR01)
    • 03 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 11 oct 2011
    Entregado el 13 oct 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currency unit, and the debt or debts from time to time.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    Deed of accession to debenture
    Creado el 11 oct 2011
    Entregado el 13 oct 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As the Security Agent)
    Transacciones
    • 13 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 01 abr 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of admission
    Creado el 28 jun 2010
    Entregado el 09 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 26 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession
    Creado el 28 jun 2010
    Entregado el 09 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and/or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 09 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 26 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 23 feb 2009
    Entregado el 27 feb 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 27 feb 2009Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Creado el 23 jul 2007
    Entregado el 07 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Company canada life policy number 6024081 date 08/06/2007 sum £200000 life assured paul c titley together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 28 mar 2007
    Entregado el 31 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 15 dic 2006
    Entregado el 03 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any f/h or l/h property fixed plant and machinery uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • East Midlands Regional Venture Capital Fund No 1 Limited Partnership
    Transacciones
    • 03 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 15 dic 2006
    Entregado el 03 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any f/h or l/h property fixed plant and machinery uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dr Ian Wilding
    Transacciones
    • 03 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0