NORPRINT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNORPRINT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05665731
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NORPRINT LIMITED?

    • otras impresiones (18129) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra NORPRINT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NORPRINT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WILLOUGHBY (534) LIMITED04 ene 200604 ene 2006

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NORPRINT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NORPRINT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    20 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 jul 2020

    21 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 jul 2019

    30 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 jul 2018

    27 páginasLIQ03

    Destitución del liquidador por orden judicial

    18 páginasLIQ10

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    27 páginasAM22

    Informe de progreso del administrador

    26 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador hasta 21 dic 2016

    33 páginas2.24B

    Aviso de nombramiento de administrador suplente/adicional

    1 páginas2.40B

    Aviso de vacante de oficina por el administrador

    29 páginas2.39B

    Informe de progreso del administrador hasta 21 jun 2016

    21 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 29 ene 2016

    22 páginas2.24B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B/2.15B

    15 páginas2.16B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    32 páginas2.17B

    Domicilio social registrado cambiado de Horncastle Road Boston Lincolnshire PE21 9HZ a Mazars House Gelderd Road Gildersome Leeds Yorkshire LS27 7JN el 17 ago 2015

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 ene 2015

    Estado de capital el 05 ene 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 ene 2014

    Estado de capital el 10 ene 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de NORPRINT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHAMPION, David Neil
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Secretario
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    BritishAccountant130150960001
    CHAMPION, David Neil
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Director
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director152573210001
    COLCLOUGH, Roy Harry
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Director
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    EnglandBritishDirector56053020001
    JOHNSON, Paul Rowland
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Director
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishTechnical Sales Director71509040002
    LAIDLAW, Alan
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Director
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector65449270007
    WISE, John Robert
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Director
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishDivisional Director149016400001
    FRAY, Timothy John
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    Secretario
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant121161680001
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Cumberland Court
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    Secretario corporativo
    Cumberland Court
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    68522760005
    DOVE, Nicholas Charles
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Director
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director107550720001
    FAWDINGTON, Eric Alexander
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Director
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    EnglandBritishNon-Executive Director59580130001
    FRAY, Timothy John
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    Director
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector121161680001
    FRENCH, Nicholas Gordon
    6 Glebe Close
    Sibsey
    PE22 0RW Boston
    Lincolnshire
    Director
    6 Glebe Close
    Sibsey
    PE22 0RW Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritishAccountant71509080001
    SEN, Jaidip
    Brinkhall Way
    Welton
    LN2 3NS Lincoln
    25
    Lincolnshire
    Director
    Brinkhall Way
    Welton
    LN2 3NS Lincoln
    25
    Lincolnshire
    EnglandBritishAccountant136029390001
    SHOOTER, Michael William
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Director
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    United KingdomBritishProduction Director66802990002
    WILLOUGHBY CORPORATE REGISTRARS LIMITED
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    Director corporativo
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    95689040001

    ¿Tiene NORPRINT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 05 dic 2013
    Entregado el 17 dic 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 17 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    Chattel mortgage
    Creado el 22 ago 2012
    Entregado el 29 ago 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each of the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Nortag dynamic rf/rfid security tag laminator serial no M677 (rebuilt 2005), mark andy 4150-16B 16" 4 colour flexopress converter serial no 1005580 (1998) and mark andy norprint po washer tag converter serial no 061102 (for full list of mortgaged chattels please see form MG01) fixed charge all plant and machinery and the benefit of all rights and claims in respect of the design construction repair or replacement of the same see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 29 ago 2012Registro de un cargo (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity
    Creado el 22 ago 2012
    Entregado el 29 ago 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Capital Bank Limited
    Transacciones
    • 29 ago 2012Registro de un cargo (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity
    Creado el 22 ago 2012
    Entregado el 29 ago 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 29 ago 2012Registro de un cargo (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creado el 28 abr 2011
    Entregado el 04 may 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 04 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    Chattel mortgage
    Creado el 30 jun 2010
    Entregado el 03 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge on all plant and machinery being- arsoma EM410 8 colour flexopress printing line s/no 410-293. arsoma EM410 13 station modular litho/flexopress printing line s/no 410-218. additional interchangeable modules including 3 x 24" litho printing heads (for further details of chattels charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 03 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    Chattel mortgage
    Creado el 16 abr 2010
    Entregado el 23 abr 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fised charges all its plant and machinery,the benefit of all the company's rights and claims,the benefits arising under the policies see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 23 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creado el 16 abr 2010
    Entregado el 23 abr 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • G E Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 23 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    Rent deposit deed
    Creado el 31 ene 2008
    Entregado el 06 feb 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £150,000.00 in a seprate interest-earning deposit account.
    Personas con derecho
    • Norcros Estates Limited
    Transacciones
    • 06 feb 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 27 abr 2006
    Entregado el 04 may 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 may 2006Registro de un cargo (395)
    Guarantee & debenture
    Creado el 30 ene 2006
    Entregado el 15 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited and magnadata group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Securities Limited
    Transacciones
    • 15 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Creado el 30 ene 2006
    Entregado el 14 feb 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 14 feb 2006Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene NORPRINT LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 jul 2015Inicio de la administración
    22 jul 2017Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Robert David Adamson
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Patrick Alexander Lannagan
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Profesional
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester
    2
    FechaTipo
    22 jul 2017Inicio de la liquidación
    23 jun 2021Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Robert David Adamson
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Patrick Alexander Lannagan
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Profesional
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Conrad Alexander Pearson
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Profesional
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0