INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05797796 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3rd Floor 3 - 5 Charlotte Street M1 4HB Manchester England England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALNERY NO. 2596 LIMITED | 27 abr 2006 | 27 abr 2006 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr John Gerard Connelly el 07 oct 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr James Peter Marsh como director el 30 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Daniel Colin Ward como director el 30 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 32 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr John Gerard Connelly como director el 12 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Conor Mcmanus como director el 12 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Barry Paul Millsom el 21 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Conor Mcmanus como director el 02 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Barry Paul Millsom como director el 21 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Michael James Williams como director el 21 dic 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Neeti Mukundrai Anand como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Alexander Victor Thorne como director el 21 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jonathan Laurence David Carter como director el 21 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr William John Payne como director el 27 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 32 páginas | AA | ||
Nombramiento de Albany Secretariat Limited como secretario el 17 abr 2023 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Paul James Hatcher como secretario el 17 abr 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 32 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Jonathan Laurence David Carter el 03 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Jonathan Laurence David Carter como director el 03 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Anthony Robert Faulkner como director el 03 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY SECRETARIAT LIMITED | Secretario corporativo | 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England |
| 303585870001 | ||||||||||
| CONNELLY, John Gerard | Director | c/o Cvc 80 Strand WC2R 0RE London 4th Floor England | England | British | 323811250001 | |||||||||
| MARSH, James Peter | Director | More London Riverside SE1 2AQ London 3 England | United Kingdom | British | 278818400039 | |||||||||
| MILLSOM, Barry Paul | Director | c/o Albany Spc Services Limited 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England | England | British | 317674240002 | |||||||||
| PAYNE, William John | Director | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange England | United Kingdom | British | 215789590001 | |||||||||
| PEARMAN, Katherine Anne Louise | Director | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 226963920001 | |||||||||
| SAVJANI, Kalpesh | Director | More London Riverside SE1 2AQ London 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 185483460002 | |||||||||
| WILLIAMS, Michael James | Director | c/o Albany Spc Services Limited 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England | England | British | 263619910002 | |||||||||
| HATCHER, Paul James | Secretario | 3 - 5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England England | 294320280001 | |||||||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Secretario designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||||||
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| ANAND, Neeti Mukundrai | Director | Level 4 2-4 Idol Lane EC3R 5DD London Dif Uk United Kingdom | England | British | 250186840001 | |||||||||
| BLANCHARD, David Graham | Director | c/o C/O Amber Infrastructure Limited London Bridge SE1 9RA London Two England | England | British | 148329480001 | |||||||||
| BRADBURY, Richard George | Director | Beech Cottage Beech Lane WA6 6LP Norley Cheshire | British | 42234330002 | ||||||||||
| BRAND, Susan Heather Charlotte | Director | Vanwall Business Park SL6 4UB Maidenhead Costain House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 179233660001 | |||||||||
| CARTER, Jonathan Laurence David | Director | One Bartholomew Close EC1A 7BL London Level 7 England | United Kingdom | British | 300727920001 | |||||||||
| CASHIN, Benjamin Matthew | Director | Dryden Road NE9 5DA Gateshead 199 Tyne And Wear | United Kingdom | British | 131562890001 | |||||||||
| CHANNON, Martin | Director | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building | England | British | 82663750001 | |||||||||
| CONNELLY, John Gerard | Director | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | Scotland | British | 152971000001 | |||||||||
| COOPER, Phillip John | Director | 126 Broad Hinton RG10 0XH Twyford Berkshire | United Kingdom | British | 116775310001 | |||||||||
| CORBITT, Morton Bruce | Director | Longdyke Merrow Lane GU4 7BD Guildford Surrey | England | British | 117809710001 | |||||||||
| COTTRELL, Keith | Director | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building | England | British | 88691090005 | |||||||||
| DE COURCY ASTON, Helen | Director | 24 Wincham Road M33 4PL Sale Cheshire | British | 117809530001 | ||||||||||
| ENGLISH, Nick Stuart | Director | London Bridge SE1 9RA London Two England | United Kingdom | British | 162468030001 | |||||||||
| FAULKNER, Anthony Robert | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London Infrared Capital Partners England | United Kingdom | British | 214155150001 | |||||||||
| FAVRE, Sarah Elisabeth Madeleine | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | French | 261338430001 | |||||||||
| GHAFOOR, Asif | Director | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 277343840001 | |||||||||
| GHAFOOR, Asif | Director | 2 Wolsey Road N1 4QH Islington | United Kingdom | British | 277343840001 | |||||||||
| GRANT, Stewart Chalmers | Director | Level 4 2 - 4 Idol Lane EC3R 5DD London Dif Uk United Kingdom | England | British | 255209380001 | |||||||||
| GRANT, Stewart Chalmers | Director | Level 4 2-4 Idol Lane EC3R 5DD London Dif Uk England | United Kingdom | British | 206362380001 | |||||||||
| GREGORY, Michael John | Director | c/o Amber Infrastructure Limited More London Riverside SE1 2AQ London 3 England | United Kingdom | British | 114324790003 | |||||||||
| GREGORY, Michael John | Director | London Bridge SE1 9RA London Two England | United Kingdom | British | 114324790003 | |||||||||
| HALL SMITH, James Edward | Director | Abbey Oak Wherwell SP11 7HY Andover Hampshire | United Kingdom | British | 86362140001 | |||||||||
| HANDFORD, Alistair John | Director | Rowleys Freith RG9 6PR Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 58215600004 | |||||||||
| LAMSTAES, Pierre Gaetan | Director | Vanwall Road SL6 4UB Maidenhead Costain House England | England | British | 180143520001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INTEGRATED BRADFORD SPV ONE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Bradford Hold Co One Limited | 06 abr 2016 | 3 - 5 Charlotte Street M1 4HB Manchester 3rd Floor England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0