EVOLVE ENERGY LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | EVOLVE ENERGY LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05831752 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EVOLVE ENERGY LTD?
- Instalación eléctrica (43210) / Construcción
¿Dónde se encuentra EVOLVE ENERGY LTD?
| Dirección de la sede social | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Cheshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EVOLVE ENERGY LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EVOLVE ENERGY LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Nombramiento de Nathan Sanders como director el 03 may 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Bradley como director el 12 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Aled Robert Humphreys como director el 12 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Brian Dominic Sharma como secretario el 18 sept 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Archie Stuart Waddell como secretario el 18 sept 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Brian Dominic Sharma como secretario el 05 jul 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Archie Stuart Waddell como secretario el 05 jul 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Mcphillimy como director el 31 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Brian Dominic Sharma como secretario el 11 may 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Veronica Mary Niven como secretario el 11 may 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Brinsley Sheridan como director el 15 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Aled Robert Humphreys como director el 12 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 21 mar 2014 | 16 páginas | RP04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EVOLVE ENERGY LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARMA, Brian Dominic | Secretario | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | 250773850001 | |||||||
| BRADLEY, Peter | Director | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Sse Enterprise Energy Solutions Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75211210001 | |||||
| GREENHORN, Kevin David Andrew | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth Grampian House Scotland | Scotland | British | 145709970001 | |||||
| SANDERS, Nathan | Director | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | England | British | 150936520002 | |||||
| BUDD, Gerald Lance | Secretario | Manston Road GU4 7YE Guildford 4 Surrey | British | 20717760001 | ||||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Secretario | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | 170751860001 | |||||||
| NIVEN, Veronica Mary | Secretario | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | 190141550001 | |||||||
| PARKE, Gary | Secretario | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| SCHNEIDER, Tim | Secretario | Citra Barn Frizers Farm Sonning Eye RG4 6TN Reading Berkshire | Canadian | 117731640001 | ||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Secretario | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 208039170001 | |||||||
| TOPP, Janice Susan | Secretario | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Other | 139112080001 | ||||||
| WADDELL, Archie Stuart | Secretario | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 234996520001 | |||||||
| DUPORT SECRETARY LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Southfield Road BS9 3BH Westbury On Trym The Bristol Office Bristol | 900020060001 | |||||||
| BAETZ, Michael | Director | 161 Bay Street, Suite 4540 PO BOX 709 M5J2S1 Toronto Canada Trust Tower Ontario Canada | Canada | Canadian | 166562600001 | |||||
| FRIGHT, Neil Grant | Director | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 165864840002 | |||||
| HIGGINS, Vanessa Claire | Director | Denchworth OX12 0DX Wantage Denchworth Manor Oxfordshire United Kingdom | England | British | 139427570001 | |||||
| HILLMAN, Christopher Michael | Director | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | England | British | 17572470002 | |||||
| HUMPHREYS, Aled Robert | Director | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 200150330001 | |||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Director | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | England | British | 18996670003 | |||||
| MCPHILLIMY, James | Director | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | British | 94397700001 | |||||
| NIVEN, Veronica Mary | Director | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 173743440001 | |||||
| PARKE, Gary | Director | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| ROTHERHAM, David Scott | Director | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 146140260002 | |||||
| SCHNEIDER, Timothy John | Director | Wyatt Close Wargrave RG10 8EB Reading 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 150003200001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Director | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Director | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHLESINGER, Joseph Charles | Director | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Canada | Canadian | 139607450001 | |||||
| SOPER, Daniel | Director | 20 Grey Road Toronto Ontario M5m 4ez Canada | Canadian | 117597800001 | ||||||
| STEVENSON, Lawrence Napier | Director | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Canada | Canadian | 131305220002 | |||||
| TENNENT, Colin Robert | Director | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | England | British | 23661940005 | |||||
| DUPORT DIRECTOR LIMITED | Director designado corporativo | 2 Southfield Road Westbury-On-Trym BS9 3BH Bristol | 900020050001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EVOLVE ENERGY LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Energy Solutions Group Bidco Limited | 06 abr 2016 | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene EVOLVE ENERGY LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 02 nov 2012 Entregado el 10 nov 2012 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 25 jul 2012 Entregado el 15 ago 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, all equipment see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 21 jul 2011 Entregado el 29 jul 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and the obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 jun 2008 Entregado el 24 jun 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Pledge | Creado el 30 nov 2006 Entregado el 14 dic 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £850,000.00 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Share capital in ashdown control services limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0