EVOLVE ENERGY LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEVOLVE ENERGY LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05831752
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EVOLVE ENERGY LTD?

    • Instalación eléctrica (43210) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra EVOLVE ENERGY LTD?

    Dirección de la sede social
    Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Cheshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EVOLVE ENERGY LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EVOLVE ENERGY LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Nombramiento de Nathan Sanders como director el 03 may 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter Bradley como director el 12 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Aled Robert Humphreys como director el 12 abr 2019

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    8 páginasAA

    Nombramiento de Brian Dominic Sharma como secretario el 18 sept 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Archie Stuart Waddell como secretario el 18 sept 2018

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Brian Dominic Sharma como secretario el 05 jul 2017

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Archie Stuart Waddell como secretario el 05 jul 2017

    2 páginasAP03

    Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de James Mcphillimy como director el 31 oct 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Brian Dominic Sharma como secretario el 11 may 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Veronica Mary Niven como secretario el 11 may 2016

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 mar 2016

    Estado de capital el 03 mar 2016

    • Capital: GBP 29,999,964.76
    SH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Richard Brinsley Sheridan como director el 15 oct 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Aled Robert Humphreys como director el 12 ago 2015

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 21 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jul 2015

    Estado de capital el 02 jul 2015

    • Capital: GBP 29,999,964.76
    SH01

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 21 mar 2014

    16 páginasRP04

    ¿Quiénes son los directivos de EVOLVE ENERGY LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHARMA, Brian Dominic
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    Secretario
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    250773850001
    BRADLEY, Peter
    Ocean Court
    Caspian Road, Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Sse Enterprise Energy Solutions
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Ocean Court
    Caspian Road, Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Sse Enterprise Energy Solutions
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75211210001
    GREENHORN, Kevin David Andrew
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    Director
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    ScotlandBritish145709970001
    SANDERS, Nathan
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    Director
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    EnglandBritish150936520002
    BUDD, Gerald Lance
    Manston Road
    GU4 7YE Guildford
    4
    Surrey
    Secretario
    Manston Road
    GU4 7YE Guildford
    4
    Surrey
    British20717760001
    LOCHERY, Anthony Francis
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    170751860001
    NIVEN, Veronica Mary
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    Secretario
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    190141550001
    PARKE, Gary
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British118299620001
    SCHNEIDER, Tim
    Citra Barn Frizers Farm
    Sonning Eye
    RG4 6TN Reading
    Berkshire
    Secretario
    Citra Barn Frizers Farm
    Sonning Eye
    RG4 6TN Reading
    Berkshire
    Canadian117731640001
    SHARMA, Brian Dominic
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    208039170001
    TOPP, Janice Susan
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    Secretario
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    Other139112080001
    WADDELL, Archie Stuart
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Secretario
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    234996520001
    DUPORT SECRETARY LIMITED
    2 Southfield Road
    BS9 3BH Westbury On Trym
    The Bristol Office
    Bristol
    Secretario designado corporativo
    2 Southfield Road
    BS9 3BH Westbury On Trym
    The Bristol Office
    Bristol
    900020060001
    BAETZ, Michael
    161 Bay Street, Suite 4540
    PO BOX 709
    M5J2S1 Toronto
    Canada Trust Tower
    Ontario
    Canada
    Director
    161 Bay Street, Suite 4540
    PO BOX 709
    M5J2S1 Toronto
    Canada Trust Tower
    Ontario
    Canada
    CanadaCanadian166562600001
    FRIGHT, Neil Grant
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish165864840002
    HIGGINS, Vanessa Claire
    Denchworth
    OX12 0DX Wantage
    Denchworth Manor
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    Denchworth
    OX12 0DX Wantage
    Denchworth Manor
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish139427570001
    HILLMAN, Christopher Michael
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish17572470002
    HUMPHREYS, Aled Robert
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    Director
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish200150330001
    LOCHERY, Anthony Francis
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish18996670003
    MCPHILLIMY, James
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Director
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish94397700001
    NIVEN, Veronica Mary
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish173743440001
    PARKE, Gary
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Marchwood
    The Crescent Lower Shiplake
    RG9 3LL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British118299620001
    ROTHERHAM, David Scott
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish146140260002
    SCHNEIDER, Timothy John
    Wyatt Close
    Wargrave
    RG10 8EB Reading
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Wyatt Close
    Wargrave
    RG10 8EB Reading
    5
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomCanadian150003200001
    SHERIDAN, Richard Brinsley
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    Director
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish192888360001
    SHERIDAN, Richard Brinsley
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Caspian Road, Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish192888360001
    SHLESINGER, Joseph Charles
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    Director
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    CanadaCanadian139607450001
    SOPER, Daniel
    20 Grey Road
    Toronto
    Ontario M5m 4ez
    Canada
    Director
    20 Grey Road
    Toronto
    Ontario M5m 4ez
    Canada
    Canadian117597800001
    STEVENSON, Lawrence Napier
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    Director
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    CanadaCanadian131305220002
    TENNENT, Colin Robert
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    Director
    Roman Way
    Longridge Road
    PR2 5BE Preston
    70-71
    Lancashire
    EnglandBritish23661940005
    DUPORT DIRECTOR LIMITED
    2 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BH Bristol
    Director designado corporativo
    2 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BH Bristol
    900020050001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EVOLVE ENERGY LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Caspian Road
    Atlantic Street
    WA14 5HH Altrincham
    Ocean Court
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07187066
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene EVOLVE ENERGY LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 02 nov 2012
    Entregado el 10 nov 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (T/a Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 10 nov 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 10 feb 2015Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    Debenture
    Creado el 25 jul 2012
    Entregado el 15 ago 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, all equipment see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bbtps L.P
    Transacciones
    • 15 ago 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 13 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 21 jul 2011
    Entregado el 29 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and the obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details.
    Personas con derecho
    • Centric Spv 1 Limited
    Transacciones
    • 29 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 08 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 20 jun 2008
    Entregado el 24 jun 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jun 2008Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Pledge
    Creado el 30 nov 2006
    Entregado el 14 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £850,000.00 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Share capital in ashdown control services limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Peter Brian Lovering, Nigel John Burnett, Sue Lovering and John Quinn
    Transacciones
    • 14 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 17 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0