ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05852393 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED?
- Actividades hospitalarias (86101) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED?
Dirección de la sede social | 2 Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood Hertfordshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
PARTNERSHIPS IN CARE PROPERTY 23 LIMITED | 20 jun 2006 | 20 jun 2006 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 jul 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 17 jul 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 jul 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Lesley Joy Chamberlain como director el 24 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2023 | 19 páginas | AA | ||
legacy | 51 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Colin Bruce Mccready como director el 27 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Keith James Anthony Browner como director el 31 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2022 au 30 jun 2023 | 1 páginas | AA01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 19 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Sarah Juliette Livingston como director el 08 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cancelación total de la carga 058523930003 | 1 páginas | MR04 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Sarah Juliette Livingston como director el 14 jun 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Sarah Juliette Livingston como secretario el 14 jun 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr John Philip Rowland como secretario el 14 jun 2021 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2018 | 15 páginas | AA | ||
legacy | 50 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
¿Quiénes son los directivos de ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROWLAND, John Philip | Secretario | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | 284189020001 | |||||||
HAQUE, Quazi Shams Mahfooz, Dr | Director | Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Imperial Place Hertfordshire United Kingdom | England | British | Group Medical Director | 168033190001 | ||||
MCCREADY, Colin Bruce | Director | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 205913080002 | ||||
JOHNSON, Sian | Secretario | 2 Quernmore Road N4 4QU London | British | 53048070004 | ||||||
LIVINGSTON, Sarah Juliette | Secretario | Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Imperial Place Hertfordshire United Kingdom | British | 175719400001 | ||||||
ROOK, Tony | Secretario | Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Imperial Place Hertfordshire | British | 132409690025 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario corporativo | 1 Mitchell Lane BS1 6BU Bristol | 111451340001 | |||||||
BARKER, David Robert | Director | Paternoster Square EC4M 7AG London Warwick Court | United Kingdom | British | Investment Director | 67233910001 | ||||
BROWNER, Keith James Anthony | Director | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | Chief Financial Officer | 175293410001 | ||||
CHAMBERLAIN, Lesley Joy | Director | Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Imperial Place Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 148001260001 | ||||
GIBSON, Rebecca Fleur | Director | Paternoster Square EC4M 7AG London Warwick Court | United Kingdom | British | Financier | 125754490001 | ||||
LANE, Simon | Director | Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Imperial Place Hertfordshire | Uk | British | Accountant | 170295510001 | ||||
LIVINGSTON, Sarah Juliette | Director | Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | Commercial Director | 273172740001 | ||||
ROBSON, Mark | Director | 2 Imperial Place Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood Hertfordshire | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 236456890001 | ||||
ROWLANDS, Simon Nicholas | Director | 27 Hyde Park Gate SW7 5DJ London | United Kingdom | British | Company Director | 40561640003 | ||||
SINCLAIR-BROWN, Frederick John | Director | Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Imperial Place Hertfordshire | England | British | Company Director | 147995700001 | ||||
THOMAS, Peter Martin | Director | Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Imperial Place Hertfordshire | England | British | Accountant | 32946180003 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director corporativo | 1 Mitchell Lane BS1 6BU Bristol | 93433510001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elysium Healthcare Limited | 04 oct 2016 | Imperial Place, Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Imperial Place England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Partnerships In Care Investments 2 Limited | 06 abr 2016 | Imperial Place, Maxwell Road WD6 1JN Borehamwood 2 Imperial Place England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene ELYSIUM HEALTHCARE PROPERTY 4 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 14 jun 2018 Entregado el 21 jun 2018 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Leasehold property known as 84, 86 and 88 bromley road, london SE6 2UR registered at hm land registry under title number TGL463111. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 26 ene 2017 Entregado el 30 ene 2017 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Leasehold bromley road 84,86 88 bromley road london title no TGL463111. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Security accession deed | Creado el 07 sept 2006 Entregado el 21 sept 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to beocme due from any chargor or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0