SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED

SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05879184
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INTERCEDE 2138 LIMITED18 jul 200618 jul 2006

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    4 páginas4.71

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    2 páginasAD02

    Cese del nombramiento de Jeffrey Herman Miller como director el 11 feb 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Erin Carol Ibele como director el 11 feb 2013

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Jonathan Mark Harper como director el 11 feb 2013

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Andrew Crabtree como director el 11 feb 2013

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Lacon House 84 Theobalds Road London WC1X 8RW United Kingdom el 22 feb 2013

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 11 feb 2013

    LRESSP

    Nombramiento de Ms Erin Carol Ibele como director el 09 ene 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Michael Andrew Crabtree como director el 09 ene 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Jeffrey Herman Miller como director el 09 ene 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Eps Secretaries Limited como secretario el 22 ene 2013

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de State Street Secretaries (Uk) Limited como secretario el 22 ene 2013

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Rachel Dryden como director el 09 ene 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Mark Harper como director el 09 ene 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steven Antony Scally como director el 09 ene 2013

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 20 Churchill Place Canary Wharf London E14 5HJ el 29 ene 2013

    1 páginasAD01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor Phoenix House 18 King William Street London EC4N 7BP el 09 nov 2012

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de James Rufus Jones como director el 16 oct 2012

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 18 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital31 jul 2012

    Estado de capital el 31 jul 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de Tuvi Keinan como director el 28 mar 2012

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EPS SECRETARIES LIMITED
    c/o Nabarro Llp
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon House
    England
    Secretario corporativo
    c/o Nabarro Llp
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2231995
    67339580001
    HARPER, Jonathan Mark
    Suite C
    10 Penn Road
    HP9 2PW Beaconsfield
    Sunrise Senior Living
    Buckinghamshire
    England
    Director
    Suite C
    10 Penn Road
    HP9 2PW Beaconsfield
    Sunrise Senior Living
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishAccountant166169730001
    GORDON, Iain
    The Ridgeway
    SL7 3LQ Marlow
    9
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    The Ridgeway
    SL7 3LQ Marlow
    9
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British135187090001
    MILLIKEN, Alistair
    34 Elwill Way
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    Secretario
    34 Elwill Way
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    British74424700001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    STATE STREET SECRETARIES (UK) LIMITED
    Phoenix House
    18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st Floor
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Phoenix House
    18 King William Street
    EC4N 7BP London
    1st Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3691921
    108845150006
    ADAMS, Carl George
    4746 Holly Ave
    IRISH Fairfax
    Virginia 22030
    Usa
    Director
    4746 Holly Ave
    IRISH Fairfax
    Virginia 22030
    Usa
    AmericanTreasurer123180810001
    CASH, Mark John
    Woes Cottage
    Church Street
    RH12 3EA Rudgwick
    West Sussex
    Director
    Woes Cottage
    Church Street
    RH12 3EA Rudgwick
    West Sussex
    EnglandBritishDirector142633680001
    CRABTREE, Michael Andrew
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Director
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    UsaUs CitizenSenior Vice President & Treasurer175436800001
    DRYDEN, Rachel
    Elmthorpe Road
    Wolvercote
    OX2 8PA Oxford
    42
    United Kingdom
    Director
    Elmthorpe Road
    Wolvercote
    OX2 8PA Oxford
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector Of Asset Management137848010005
    HARPER, Jonathan Mark
    16 Warwick Road
    HP9 2PE Beaconsfield
    Crofton House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    16 Warwick Road
    HP9 2PE Beaconsfield
    Crofton House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant166169730001
    IBELE, Erin Carol
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Director
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    UsaAmericanSenior Vice President - Admin And Co Secretary175434470001
    JONES, James Rufus
    King William Street
    EC4N 7BP London
    1st Floor Phoenix House 18
    Director
    King William Street
    EC4N 7BP London
    1st Floor Phoenix House 18
    United KingdomUs CitizenInvestment Banker139882360001
    KEINAN, Tuvi
    3 Nutley Terrace
    NW3 5BX London
    Director
    3 Nutley Terrace
    NW3 5BX London
    United KingdomBritishBanker80469170002
    MARSH, David
    The Shieling
    Lower Rads End Tingrith Road
    MK17 9EF Eversholt
    Bedfordshire
    Director
    The Shieling
    Lower Rads End Tingrith Road
    MK17 9EF Eversholt
    Bedfordshire
    EnglandBritishManaging Director142633710001
    MAYR, Lisa-Beth
    6010 Softwood Trail
    Mclean
    Virginia 22101
    Director
    6010 Softwood Trail
    Mclean
    Virginia 22101
    United StatesAmericanTreasurer And Svp214324110001
    MILLER, Jeffrey Herman
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Director
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    United States Of AmericaUs CitizenExecutive Vice President - Ops & General Counsel171919780001
    MILSTEIN, Paul Scott
    10916 Blue Roan Road
    IRISH Oakton
    Virginia 22124
    Usa
    Director
    10916 Blue Roan Road
    IRISH Oakton
    Virginia 22124
    Usa
    UsaUnited StatesSenior Vice President Finance142614120001
    POPE, James Sulkirk
    Wyandot Court
    Bethesda
    LMVBKZUQ Maryland
    5011
    20816
    United States
    Director
    Wyandot Court
    Bethesda
    LMVBKZUQ Maryland
    5011
    20816
    United States
    United StatesSup Finance130583780001
    RAPLEY, Vincent Michael
    King William Street
    EC4N 7BP London
    1st Floor Phoenix House 18
    Director
    King William Street
    EC4N 7BP London
    1st Floor Phoenix House 18
    EnglandBritishBanker97416440001
    RUSH, Bradley Burnett
    371 Church St. Ne
    IRISH Vienna
    Virginia 22180
    Usa
    Director
    371 Church St. Ne
    IRISH Vienna
    Virginia 22180
    Usa
    AmericanChief Officer Financial114799100001
    SCALLY, Steven Antony
    House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon
    United Kingdom
    Director
    House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Lacon
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector129486460001
    TOMASSO, Tiffany Lynn
    12834 Parapet Way
    IRISH Oak Hill
    Virginia Va 20171
    Usa
    Director
    12834 Parapet Way
    IRISH Oak Hill
    Virginia Va 20171
    Usa
    AmericanExecutive Vice President90046730001
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Director corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    80754520001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Director corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001

    ¿Tiene SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 28 sept 2006
    Entregado el 13 oct 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All prsent and future uncalled capital and goodwill,all existing and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 oct 2006Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene SUNRISE HOME HELP SOUTHBOURNE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 feb 2013Inicio de la liquidación
    02 ene 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0