VENICE NEWCO 2 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | VENICE NEWCO 2 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 05879450 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de VENICE NEWCO 2 LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra VENICE NEWCO 2 LIMITED?
Dirección de la sede social | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VENICE NEWCO 2 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BUBBLECLOSE LIMITED | 18 jul 2006 | 18 jul 2006 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de VENICE NEWCO 2 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para VENICE NEWCO 2 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 058794500006 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Registro de la carga 058794500006, creada el 10 oct 2018 | 75 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 058794500005 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 058794500004 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaraci ón de confirmación presentada el 08 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Gail Susan Hunter el 10 jun 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Anthony Gerrard Troy el 10 jun 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Registro de la carga 058794500005, creada el 01 dic 2015 | 85 páginas | MR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr James Alexander Burrell como director el 10 nov 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Registro de la carga 058794500004 | 91 páginas | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de VENICE NEWCO 2 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURRELL, James Alexander | Director | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 192486560001 | ||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Director | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | Irish | Finance Director | 185108770001 | ||||
HUNTER, Gail Susan | Director | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Human Resources Director | 156206540001 | ||||
TROY, Anthony Gerrard | Director | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | Irish | Director | 104500230001 | ||||
BENNISON, Matthew Edward | Secretario | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | 161879190001 | |||||||
DOUBLEDAY, Timothy | Secretario | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | British | 156119060001 | ||||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Secretario | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | Company Secretary | 185108770001 | |||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
BENNISON, Matthew Edward | Director | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | British | Company Director | 108534390002 | ||||
BURRELL, James | Director | 79 Disraeli Road SW15 2DR London | British | Investment Executive | 115775330001 | |||||
CLARKE, Martin Andrew, Dr | Director | 35 The Bromptons Rose Square SW3 6RS London Uk | United Kingdom | British | Partner At Private Equity Hous | 121053560001 | ||||
DAY, Mark | Director | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | England | British | Director | 124446000001 | ||||
DOUBLEDAY, Timothy John | Director | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 91011320001 | ||||
FLANAGAN, Sally Deborah | Director | 10 Cobden Hill WD7 7JR Radlett Hertfordshire | England | British | Investment Executive | 116577710001 | ||||
LEVY, Adrian Joseph Morris | Director | 2 Carlisle Gardens HA3 0JX Harrow Middlesex | United Kingdom | British | Solicitor | 147682410001 | ||||
NISBETT, Paul Sandle | Director | The Grove Bletchley MK3 6BZ Milton Keynes 5 Buckinghamshire | England | British | Company Director | 132613500001 | ||||
PUDGE, David John | Director designado | 20 Herondale Avenue SW18 3JL London | British | 900028170001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de VENICE NEWCO 2 LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venice Newco 1 Limited | 06 abr 2016 | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene VENICE NEWCO 2 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 10 oct 2018 Entregado el 11 oct 2018 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 01 dic 2015 Entregado el 03 dic 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 12 jun 2014 Entregado el 18 jun 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
English law deed of accession | Creado el 27 feb 2013 Entregado el 01 mar 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Share mortgage and security assignment over receivables | Creado el 01 dic 2011 Entregado el 13 dic 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any obligor or the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All the subsidiary shares and all corresponding distribution rights and related rights floating charge all its assets and undertakings see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Share mortgage and security assignment over receivables | Creado el 29 nov 2010 Entregado el 04 dic 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The subsidiary shares and all corresponding distribution rights and related rights by way of floating charge all its assets and undertaking see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0