PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05884160 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED?
| Dirección de la sede social | 25 Farringdon Street EC4A 4AB London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 24 jul 2023 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 10 páginas | LIQ13 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de First Floor Templeback 10 Temple Back Bristol BS1 6FL England a 30 Park Street London SE1 9EQ | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada First Floor Templeback 10 Temple Back Bristol BS1 6FL | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 4-6 Colebrooke Place London N1 8HZ a 25 Farringdon Street London EC4A 4AB el 17 jul 2024 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Vikki Louise Everett como director el 15 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Martin Timothy Smith como director el 19 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Nicola Covington como director el 19 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2023 au 30 sept 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Mark Richard Batchelor como director el 25 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon William Vevers como director el 25 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Frank David Laing como director el 23 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Karen Marie Hill como director el 02 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neal John Ackcral como director el 24 sept 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
| 97584300011 | ||||||||||
| ACKCRAL, Neal John | Director | 30 Park Street SE1 9EQ London Hyde Housing United Kingdom | United Kingdom | British | 103881880001 | |||||||||
| BATCHELOR, Mark Richard | Director | SE1 9EQ London 30 Park Street United Kingdom | United Kingdom | British | 309610640001 | |||||||||
| COVINGTON, Nicola | Director | 280 Bishopsgate EC2M 4AG London Abrdn Plc England | United Kingdom | British | 207391580001 | |||||||||
| DOUGLASS, Charlotte Sophie Ellen | Director | Welken House 10-11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Eqitex Ltd United Kingdom | United Kingdom | British | 245967540001 | |||||||||
| LAING, Frank David | Director | EH2 2LL Edinburgh 1 George Street , United Kingdom United Kingdom | Scotland | British | 256185820002 | |||||||||
| CROSS, Stephen | Secretario | 2 Breach Cottages Breach Lane Upchurch ME9 7PE Sittingbourne Kent | British | 3480870003 | ||||||||||
| HAYNES, Victoria | Secretario | Basted Lane Crouch, Borough Green TN15 8PY Sevenoaks Dove Cottage Kent England | British | 182412280001 | ||||||||||
| ALLISON, Tracy Helen | Director | 30 Park Street SE1 9EQ London The Hyde Group United Kingdom | United Kingdom | British | 181406590001 | |||||||||
| BRIDGE, Paul | Director | 26 Waghorn Street SE15 4JZ London | England | British | 201420230001 | |||||||||
| CHARLESWORTH, Andrew Gilbert | Director | c/o John Laing 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | United Kingdom | British | 155424980001 | |||||||||
| CHATFIELD, Simon Craig | Director | Yorke Road RH2 9HH Reigate 21 Surrey England | England | British | 76670050002 | |||||||||
| CHRISTOPHER, Raymond Gary | Director | Hayward Road KT7 0BF Thames Ditton 3 Surrey | England | British | 135981290001 | |||||||||
| DUGGAN, Kevin Barry | Director | 1 Ash Tree Court Ash Tree Drive TN15 6LT West Kingsdown Kent | England | British | 5330260003 | |||||||||
| EVERETT, Vikki Louise | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 97009800001 | |||||||||
| GANNICOTT, David Keith | Director | SE1 9EQ London 30 Park Street United Kingdom | England | British | 118321250001 | |||||||||
| HILL, Karen Marie | Director | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 United Kingdom | England | British | 104265470002 | |||||||||
| HILL, Karen Marie | Director | Durham Road East Finchley N2 9DR London 113 United Kingdom | England | British | 104265470002 | |||||||||
| JENKINSON, Jane Elizabeth | Director | Bathurst Mews W2 2SB London 16 England | England | British | 147588390001 | |||||||||
| JOHNSTON, Nicola | Director | Carholme Road SE23 2HT London First Floor Flat, 35 United Kingdom | British | 134124490001 | ||||||||||
| MCLINTOCK, Matthew Joseph | Director | WC2B 6AN London 1 Kingsway United Kingdom | England | British | 230346020001 | |||||||||
| MICKLEBURGH, Andrew Simon | Director | The Granary, Dunsdale Brasted Road TN16 1LJ Westerham Kent | England | British | 61711010004 | |||||||||
| O'SHAUGHNESSY, Conor Matthew Gerard | Director | Flat 4, 14 John Maurice Close SE17 1PZ London | United Kingdom | Irish | 115520730001 | |||||||||
| PRITCHARD, Jamie | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 172824610001 | |||||||||
| SMITH, Martin Timothy | Director | 9 Carlingnose Point KY11 1ER North Queensferry | Scotland | British | 82478070001 | |||||||||
| STEPHENS, Karen Elisabeth | Director | Navarino Road BN11 2NE Worthing 45 West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 138309330001 | |||||||||
| TIBBITTS, John Alfred Neville | Director | 30 Park Street SE1 9EQ London The Hyde Group United Kingdom | England | British | 71709970001 | |||||||||
| TITHERINGTON, Thomas Gore | Director | Hilly Fields Crescent Lewisham SE4 1QA London 13 | United Kingdom | British | 159742210001 | |||||||||
| VEVERS, Simon William | Director | Park Street SE1 9EQ London 30 United Kingdom | England | British | 115570790001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfi Islington 2 (Holdings) Limited | 31 ago 2016 | Colebrooke Place N1 8HZ London 4-6 | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 24 jul 2016 | 30 ago 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que existe una persona registrable en relación con la empresa, pero no la ha identificado. |
¿Tiene PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON 2 LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0