GOOD THINGS FOUNDATION

GOOD THINGS FOUNDATION

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGOOD THINGS FOUNDATION
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 05887661
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GOOD THINGS FOUNDATION?

    • Otra educación n.c.p. (85590) / Educación

    ¿Dónde se encuentra GOOD THINGS FOUNDATION?

    Dirección de la sede social
    Showroom Workstation
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    South Yorkshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GOOD THINGS FOUNDATION?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TINDER FOUNDATION21 jun 201321 jun 2013
    ONLINE CENTRES FOUNDATION26 jul 200626 jul 2006

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GOOD THINGS FOUNDATION?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2025
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GOOD THINGS FOUNDATION?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta24 jul 2025
    Próxima declaración de confirmación vence07 ago 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta24 jul 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GOOD THINGS FOUNDATION?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2024

    38 páginasAA

    Cese del nombramiento de Naureen Khan como director el 15 ene 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Juliet Annabel Upton como director el 15 ene 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Thomas Beautyman como director el 15 ene 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Mary Booth como director el 15 ene 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Jo Reynolds como director el 15 ene 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Hannah Jane Whelan como director el 31 dic 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Louise Olivia Branch como director el 28 nov 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Spaces - Acero 1 Concourse Way Digital Campus Sheffield S1 2BJ England a Showroom Workstation 15 Paternoster Row Sheffield South Yorkshire S1 2BX el 27 jun 2024

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Chad Paul Bond como director el 30 ene 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2023

    36 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de William John Perrin como director el 01 feb 2023

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Floor 3 Kollider Castle House Castle Street Sheffield S3 8LN England a Spaces - Acero 1 Concourse Way Digital Campus Sheffield S1 2BJ el 04 abr 2023

    1 páginasAD01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2022

    36 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Thomas Simon Hillsdon el 27 ene 2023

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr David Bernard como director el 23 ene 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Thomas Simon Hillsdon como director el 23 ene 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Vinous Ali como director el 23 ene 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Louise Olivia Branch como director el 23 ene 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Julie Hawker como director el 23 ene 2023

    2 páginasAP01

    Cancelación total de la carga 058876610001

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Sital Mistry como director el 24 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Laura Amy Faulkner como director el 20 nov 2022

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de GOOD THINGS FOUNDATION?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARLOW, Adam
    Angel Street
    S3 8LN Sheffield
    Floor 3, Kollider
    England
    Secretario
    Angel Street
    S3 8LN Sheffield
    Floor 3, Kollider
    England
    294481390001
    ALI, Vinous
    Stacy Path
    SE5 7SL London
    9
    England
    Director
    Stacy Path
    SE5 7SL London
    9
    England
    EnglandBritishDirector304597180001
    BEAUTYMAN, Thomas
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    Director
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    EnglandEnglishDeputy Director331763570001
    BERNARD, David
    Lansdowne Road
    MK40 2BY Bedford
    33
    England
    Director
    Lansdowne Road
    MK40 2BY Bedford
    33
    England
    EnglandBritish,FrenchCompany Executive304776720001
    BOOTH, Mary
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    Director
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    EnglandEnglishDigital Services Manager331699550001
    CLARE, Roy Alexander George, Rear Admiral
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    Director
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishResearcher108581800001
    HAWKER, Julie
    Heathpark Way
    Heathpark Industrial Estate
    EX14 1SF Honiton
    Cosmic, East Devon Business Centre,
    England
    Director
    Heathpark Way
    Heathpark Industrial Estate
    EX14 1SF Honiton
    Cosmic, East Devon Business Centre,
    England
    EnglandBritishBusiness Director304597000001
    HILLSDON, Thomas Simon
    North Lonsdale Street
    Stretford
    M32 0PD Manchester
    6
    England
    Director
    North Lonsdale Street
    Stretford
    M32 0PD Manchester
    6
    England
    EnglandBritishProject Manager304597740002
    MILNER, Helen Louise
    18 Priory Road
    S7 1LW Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    18 Priory Road
    S7 1LW Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishE Services Director108155510001
    REYNOLDS, Jo
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    Director
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    EnglandEnglishResearch And Evaluation Manager331699240001
    UPTON, Juliet Annabel
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    Director
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    EnglandEnglishDirector86946000001
    WALLACE DEAN, Nicola Anne
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    Director
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishProgramme Manager234895590003
    WILLIAMS, Elizabeth Alana
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    Director
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishManager166836690002
    BENNETT, Margaret Joan
    PO BOX 6063
    S11 0GU Sheffield
    Good Things Foundation
    England
    Secretario
    PO BOX 6063
    S11 0GU Sheffield
    Good Things Foundation
    England
    165341040001
    BENNETT, Pauline
    The Quadrant 99 Parkway Avenue
    Parkway Business Park
    S9 4WG Sheffield
    South Yorks
    Secretario
    The Quadrant 99 Parkway Avenue
    Parkway Business Park
    S9 4WG Sheffield
    South Yorks
    160953120001
    CARTWRIGHT, Paul
    39 Mill Hill Avenue
    WF8 4JH Pontefract
    West Yorkshire
    Secretario
    39 Mill Hill Avenue
    WF8 4JH Pontefract
    West Yorkshire
    BritishManager82198000001
    IMCO SECRETARY LIMITED
    Riverside East
    2 Millsands
    S3 8DT Sheffield
    Secretario corporativo
    Riverside East
    2 Millsands
    S3 8DT Sheffield
    82976850003
    ANDERSSON, Chris
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    Director
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    EnglandBritishMarketing And Communications Officer177946560001
    APPLEYARD, Nicholas John
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    Director
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    EnglandBritishBusiness Executive270778230001
    BARLOW, Adam
    Angel Street
    S3 8LN Sheffield
    Floor 3, Kollider
    England
    Director
    Angel Street
    S3 8LN Sheffield
    Floor 3, Kollider
    England
    EnglandEnglishDirector Of Finance294481350001
    BENNETT, Margaret Joan
    23 Endcliffe Rise Road
    S11 8RU Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    23 Endcliffe Rise Road
    S11 8RU Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishCivil Servant50726370001
    BOND, Chad Paul
    1 Concourse Way
    Digital Campus
    S1 2BJ Sheffield
    Spaces - Acero
    England
    Director
    1 Concourse Way
    Digital Campus
    S1 2BJ Sheffield
    Spaces - Acero
    England
    EnglandBritishCivil Servant239128040001
    BRANCH, Louise Olivia
    Tower Rise
    S2 3QX Sheffield
    44
    England
    Director
    Tower Rise
    S2 3QX Sheffield
    44
    England
    United KingdomBritishCommunity Engagement Manager304597080001
    BREEN, Zoe Elise
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    Director
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    EnglandBritishProducer202239050001
    BROWN, Leigh Reuben
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    Director
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    EnglandBritishHead Of Projects183442170001
    CARR, Peter Davison
    c/o 15 Paternoster Road
    15 Paternoster Road
    S1 2BX Sheffield
    The Workstation
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o 15 Paternoster Road
    15 Paternoster Road
    S1 2BX Sheffield
    The Workstation
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishEducation Manager165681180001
    CARTWRIGHT, Paul
    39 Mill Hill Avenue
    WF8 4JH Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    39 Mill Hill Avenue
    WF8 4JH Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritishManager82198000001
    CLARK, Jamie Christian
    PO BOX 6063
    S11 0GU Sheffield
    Good Things Foundation
    England
    Director
    PO BOX 6063
    S11 0GU Sheffield
    Good Things Foundation
    England
    EnglandBritishSenior Software Developer204517800001
    DARLINGTON, Roger Alessandro
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    Director
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    United KingdomBritishPortfolio Worker166849680001
    FAULKNER, Anne
    116 Gwydir Street
    CB1 2LL Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    116 Gwydir Street
    CB1 2LL Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishHead Of Policy117469290001
    FAULKNER, Laura Amy
    Ratcliffe Road
    S11 8YA Sheffield
    17
    England
    Director
    Ratcliffe Road
    S11 8YA Sheffield
    17
    England
    EnglandBritishLearning Content Manager289534210001
    HAWXWELL, Gail
    c/o 15 Paternoster Road
    15 Paternoster Road
    S1 2BX Sheffield
    The Workstation
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o 15 Paternoster Road
    15 Paternoster Road
    S1 2BX Sheffield
    The Workstation
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishNetwork Coordinator/Pa140885590001
    JEEPS, Robin Charles
    Lemont Road
    S17 4HA Sheffield
    31
    S Yorks
    Director
    Lemont Road
    S17 4HA Sheffield
    31
    S Yorks
    United KingdomBritishIt Manager131486900001
    KHAN, Naureen
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    Director
    15 Paternoster Row
    S1 2BX Sheffield
    Showroom Workstation
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishHealth & Public Service168275510001
    KNIGHT, Jim, The Rt Hon The Lord Knight Of Weymouth
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    Director
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    First Floor
    England
    Unitd KingdomBritishPolitician And Business Consultant163875210001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para GOOD THINGS FOUNDATION?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    06 mar 2018La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.
    26 jul 201606 mar 2018La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0