LASER HOTELS ONE LIMITED

LASER HOTELS ONE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLASER HOTELS ONE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05893844
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LASER HOTELS ONE LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o HUDSON ADVISORS UK LIMITED
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MREF HOTELS ONE LIMITED07 feb 200707 feb 2007
    MACDONALD HOTELS ONE LIMITED20 sept 200620 sept 2006
    BOWLFLIP LIMITED02 ago 200602 ago 2006

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 sept 2021

    8 páginasLIQ03

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 13 sept 2019

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 sept 2020

    7 páginasLIQ03

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Company be wound up voluntarily/joint liquidators appointed 13/09/2019
    RES13

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01

    Cese del nombramiento de Vincent Frederic Marc Vernier como director el 08 jul 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Vincent Vernier como secretario el 08 jul 2019

    1 páginasTM02

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Timothy Selwyn Jones como director el 13 dic 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Edward Gray como director el 24 oct 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 ago 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 058938440005

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de John Brennan como director el 04 may 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Michael Gallagher como director el 20 dic 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Darren William Guy como director el 20 dic 2017

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Vincent Vernier el 13 nov 2017

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Neal Morar como secretario el 03 oct 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Neal Morar como director el 03 oct 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Vincent Vernier como secretario el 06 oct 2017

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GALLAGHER, Michael
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Director
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    IrelandIrish243693110001
    JONES, Timothy Selwyn
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Director
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish226437520001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Secretario
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Secretario
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    197427310001
    SANDERSON, Timothy Robin Llewelyn
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Secretario
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    British69033180003
    VERNIER, Vincent
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Secretario
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    239131680001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRENNAN, John
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Director
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish211131530001
    EDWARDS, Nicholas William John
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Director
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    EnglandBritish166575000001
    FERGUSON DAVIE, Charles John
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Director
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish159387570001
    FIGGE, Heiko
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Director
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish183639640001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Director
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    United KingdomBritish120322350001
    GILBARD, Marc Edward Charles
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Director
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish29232300002
    GRAY, Robert Edward
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Director
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish188584900001
    GUILE, David Andrew
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    Director
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    United KingdomBritish100133280001
    GUY, Darren
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Director
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish294582970001
    HALL, Steven
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Director
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish147752500001
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Director
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    EnglandBritish173110500001
    SIDWELL, Graham Robert
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Director
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish72844280004
    SMITH, Gerard Henry
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    Director
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    United KingdomBritish40871240003
    STANLEY, Graham Bryan
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Director
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish46112880007
    VERNIER, Vincent Frederic Marc
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Director
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United KingdomFrench185884890003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LASER HOTELS ONE LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    02 ago 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene LASER HOTELS ONE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 18 feb 2015
    Entregado el 26 feb 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch as Trustee for Each of the Secured Parties (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 26 feb 2015Registro de una carga (MR01)
    • 21 jun 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 20 ago 2010
    Entregado el 03 sept 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 14 ago 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of pledge
    Creado el 20 ago 2010
    Entregado el 03 sept 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Pledged and charged the existing shares and any related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 14 ago 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 16 oct 2006
    Entregado el 25 oct 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselfand the Other Secured Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 oct 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 oct 2006
    Entregado el 25 oct 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselfand the Other Secured Parties (The Security Trus
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselftee)
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselfand the Other Secured Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 oct 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene LASER HOTELS ONE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    2
    FechaTipo
    13 sept 2019Inicio de la liquidación
    27 abr 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0