TOPAZ FINANCE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTOPAZ FINANCE LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05946900
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TOPAZ FINANCE LIMITED?

    • Actividades de las sociedades de financiación hipotecaria (64922) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra TOPAZ FINANCE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Harman House
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TOPAZ FINANCE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TOPAZ FINANCE PLC29 nov 200629 nov 2006
    ZESTBAY PLC26 sept 200626 sept 2006

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TOPAZ FINANCE LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2026
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2027
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TOPAZ FINANCE LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta03 feb 2027
    Próxima declaración de confirmación vence17 feb 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta03 feb 2026
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TOPAZ FINANCE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mr Aaron Richard Milburn como director el 01 may 2026

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Nigel Jones como director el 30 abr 2026

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Dr Fraser Mcleod Gemmell como director el 02 abr 2026

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Michael Thomas Gibbons como director el 30 mar 2026

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Vladislav Botic como director el 13 mar 2026

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Ganna Agafonova como director el 13 mar 2026

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Hillary Frances Elizabeth Ray como director el 13 mar 2026

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Peter Aeneas Ali como director el 13 mar 2026

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2025

    32 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2026 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2026 au 31 dic 2026

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Sharon Eeles como secretario el 01 feb 2026

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Judith Mary Matthews como secretario el 01 feb 2026

    1 páginasTM02

    Notification de Advantage Odyssey Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 feb 2026

    2 páginasPSC02

    Cessation de Computershare Investments (Uk) (No. 3) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 feb 2026

    1 páginasPSC07

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Second Floor, 1 Belle Vue Square Broughton Road Skipton BD23 1FJ

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Second Floor, 1 Belle Vue Square Broughton Road Skipton BD23 1FJ

    1 páginasAD02

    Cese del nombramiento de Timothy Alan Franklin como director el 01 feb 2026

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Lee Banks como director el 01 feb 2026

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas Stuart Robert Oldfield como director el 01 feb 2026

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de The Pavilions Bridgwater Road Bristol BS13 8AE a Harman House 1 George Street, Uxbridge London UB8 1QQ el 01 feb 2026

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 21 sept 2025 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Estado de capital el 31 mar 2025

    • Capital: GBP 100,570
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    ¿Quiénes son los directivos de TOPAZ FINANCE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EELES, Sharon
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Secretario
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    344938480001
    AGAFONOVA, Ganna
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    EnglandGerman300284700003
    BOTIC, Vladislav
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    EnglandCypriot135764660004
    GEMMELL, Fraser Mcleod, Dr
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    United KingdomNew Zealander169590340009
    GIBBONS, Michael Thomas
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    United KingdomBritish306224040001
    MILBURN, Aaron Richard
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    United KingdomNew Zealander318703310003
    RAY, Hillary Frances Elizabeth
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    IrelandIrish346349150001
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    Secretario
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    285507770001
    DOLBEAR, Jonathan
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    Secretario
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    196704620001
    ESMAIL, Rizwana
    Gargrave Road
    BD23 1UD Skipton
    Gateway House
    North Yorkshire
    England
    Secretario
    Gargrave Road
    BD23 1UD Skipton
    Gateway House
    North Yorkshire
    England
    291046400001
    MATTHEWS, Judith Mary
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Secretario
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    318498860001
    NICHOLSON, Andrew James
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    Secretario
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    181954490001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES (CCA) LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    83911920002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    140723560001
    ALI, Peter Aeneas
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    EnglandBritish225500260003
    BANKS, Richard Lee
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    WalesBritish51619890006
    BLAKEMORE, Julian Everard
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    Director
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    EnglandBritish111260450002
    CORRADINI, Claudio
    Flat 2
    20 Onslow Gardens
    SW7 3AL London
    Director
    Flat 2
    20 Onslow Gardens
    SW7 3AL London
    Italian105342310002
    COSTIGAN, Patrick Michael
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    Director
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    EnglandBritish192787350003
    DEVINE, Alan Sinclair
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Director
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    United KingdomBritish148842310001
    DRAYTON, James Henry
    34 Hendrick Avenue
    SW12 8TL London
    Director
    34 Hendrick Avenue
    SW12 8TL London
    United KingdomBritish,Australian142737210001
    FOSTER, Julian David
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    Director
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    EnglandBritish97045970003
    FRANKLIN, Timothy Alan
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    EnglandBritish229411470002
    FREELEY, Andrew Paul
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    Director
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    United KingdomBritish180908370001
    FRYERS, Paul
    Gargrave Road
    BD23 1UD Skipton
    Gateway House
    North Yorkshire
    Director
    Gargrave Road
    BD23 1UD Skipton
    Gateway House
    North Yorkshire
    EnglandBritish135549540001
    HICKEY, Mark Jonathan
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Director
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    EnglandBritish190377970001
    HOOD, James Terence
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    Director
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    EnglandBritish189833420001
    HUSSAIN, Rizwan
    1425 New Providence Wharf Block E
    1 Fairmont Avenue Canary Wharf
    E14 9QJ London
    Director
    1425 New Providence Wharf Block E
    1 Fairmont Avenue Canary Wharf
    E14 9QJ London
    British117410790001
    JONES, Andrew Nigel
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    Director
    1 George Street, Uxbridge
    UB8 1QQ London
    Harman House
    England
    EnglandBritish196786680001
    KYLE, Christopher David Barnes
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    Director
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    EnglandBritish148249080001
    LARKIN, Michael
    Rbs Gogarburn, PO BOX 1000
    EH12 1HQ Edinburgh
    Business House C
    Midlothian
    Scotland
    Director
    Rbs Gogarburn, PO BOX 1000
    EH12 1HQ Edinburgh
    Business House C
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandIrish177183790001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Director
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish147682410001
    LINDO, Robert Edward
    5 Highgate Close
    Highgate
    N6 4SD London
    Director
    5 Highgate Close
    Highgate
    N6 4SD London
    United KingdomBritish111490380003
    MARTIN, Marian Macdonald
    Gargrave Road
    BD23 1UD Skipton
    Gateway House
    North Yorkshire
    England
    Director
    Gargrave Road
    BD23 1UD Skipton
    Gateway House
    North Yorkshire
    England
    ScotlandBritish240952910001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TOPAZ FINANCE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 George Street
    UB8 1QQ Uxbridge
    Harman House
    England
    01 feb 2026
    1 George Street
    UB8 1QQ Uxbridge
    Harman House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalEngland & Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro16724229
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    08 abr 2016
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    The Pavilions
    England
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04895098
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0