ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED

ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05965421
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TRUSHELFCO (NO.3253) LIMITED12 oct 200612 oct 2006

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 059654210008

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 059654210007

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 059654210009

    4 páginasMR04

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 29 mar 2019

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2018

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 059654210005

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 059654210006

    4 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 12 oct 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Notification de Ps Confer Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2017

    2 páginasPSC02

    Cessation de Hcc Properties Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2017

    1 páginasPSC07

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2017 au 30 abr 2018

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    22 páginasAA

    Cese del nombramiento de Geraldine Josephine Gallagher como director el 31 ago 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Alexander Burrell como director el 31 ago 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gail Susan Hunter como director el 31 ago 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Anthony Gerrard Troy como director el 31 ago 2017

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de The Inspire Hornbeam Square West Harrogate North Yorkshire HG2 8PA a Ground Floor 30 City Road London EC1Y 2AB el 13 sept 2017

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Stuart Robinson como director el 31 ago 2017

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BENNETT, William Frederick
    152 West End Lane
    NW6 1SD London
    Haskell House
    United Kingdom
    Secretario
    152 West End Lane
    NW6 1SD London
    Haskell House
    United Kingdom
    237829180001
    PEARS, David Alan
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Director
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director65200910001
    PEARS, Mark Andrew
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Director
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director1447500008
    PEARS, Trevor Steven, Sir
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Director
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director40036010005
    ROBINSON, Stuart Alec
    Belmore Park
    SO32 1HQ Upham
    Belmore House
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    Belmore Park
    SO32 1HQ Upham
    Belmore House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director225321550001
    WPG REGISTRARS LIMITED
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Director corporativo
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5513520
    147590060001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Secretario
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    161757900001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156120060001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Secretario
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    SOLOMAN, Sheila Margaret
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Secretary45253560008
    TRUSEC LIMITED
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    Secretario designado corporativo
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    900007200001
    ANDERSON, Peter George
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    Director
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    BritishFinance Director70304810001
    BELLONE, Norman Edward
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    BritishManaging Director126414070001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    BURRELL, James Alexander
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Director
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant192486560001
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Director
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritishDirector124446000001
    DE GAY, Sarah
    N4
    Director
    N4
    EnglandBritishSolicitor43494570001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer91011320001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Director
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandIrishFinance Director185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Director
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishHuman Resources Director89557480002
    MONIR, Nicole Frances
    92 Crosslands
    Caddington
    LU1 4ER Luton
    Bedfordshire
    Director
    92 Crosslands
    Caddington
    LU1 4ER Luton
    Bedfordshire
    United KingdomBritishChartered Secretary102866950001
    MORGAN, Philip Douglas
    6b North Cross Road
    SE22 9EU London
    Director
    6b North Cross Road
    SE22 9EU London
    BritishSolicitor115961060001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Director
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director132613500001
    TROY, Anthony Gerrard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrishDirector104500230001
    WHELTON, Martin Anthony
    Pitt's Walk Bowling Green Close
    SW15 3TE London
    Director
    Pitt's Walk Bowling Green Close
    SW15 3TE London
    BritishSolicitor10466410002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    31 ago 2017
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro10774306
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Hcc Properties Limited
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    06 abr 2016
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    Forma jurídicaLimited Liability Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland
    Número de registro05946999
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 sept 2017
    Entregado el 07 sept 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Freehold property known as alexandra house, whittingham drive, swindon, wiltshire, SN4 0QJ comprising two title numbers and identified as land lying to the west of B4005, wroughton, swindon registered under title number WT213965 and land lying to the south east of wroughton, swindon registered under title number WT216467.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 07 sept 2017Registro de una carga (MR01)
    • 05 abr 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 01 sept 2017
    Entregado el 07 sept 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Freehold property known as alexandra house, whittingham drive, swindon, wiltshire, SN4 0QJ comprising two title numbers and identified as land lying to the west of B4005, wroughton, swindon registered under title number WT213965 and land lying to the south east of wroughton, swindon registered under title number WT216467.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 07 sept 2017Registro de una carga (MR01)
    • 05 abr 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 31 ago 2017
    Entregado el 01 sept 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Freehold property known as alexandra house, whittingham drive, swindon, wiltshire, SN4 0QJ comprising two title numbers and identified as land lying to the west of B4005, wroughton, swindon registered at the land registry under title number WT213965 and land lying to the south east of wroughton, swindon registered at the land registry under title number WT216467.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wpg Finance Limited
    Transacciones
    • 01 sept 2017Registro de una carga (MR01)
    • 05 abr 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 01 dic 2015
    Entregado el 03 dic 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Freehold property known as land lying to the west of B4005 wroughton swindon title number WT213965. Freehold property known as land lying to the south east of wroughton swindon title number WT216467.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transacciones
    • 03 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    • 11 may 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 12 jun 2014
    Entregado el 18 jun 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    F/H land lying to the west of B4005 wroughton swindon t/no WT213965,f/h land lying to the south east of wroughton swindon t/no WT216467.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transacciones
    • 18 jun 2014Registro de una carga (MR01)
    • 11 may 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    English law deed of accession
    Creado el 27 feb 2013
    Entregado el 01 mar 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 01 mar 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 27 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 dic 2011
    Entregado el 10 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 03 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 18 jun 2007
    Entregado el 22 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 03 nov 2006
    Entregado el 23 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each of the chargors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land lying to the west of B4005 wroughto. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0