BRANDSPACE GROUP LIMITED

BRANDSPACE GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRANDSPACE GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05973040
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PROMOTION SPACE GROUP LIMITED24 abr 200724 abr 2007
    COBCO 810 LIMITED20 oct 200620 oct 2006

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    17 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 mar 2018

    15 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 mar 2017

    11 páginas4.68

    Cancelación total de la carga 9

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Jane Elizabeth Vinson como director el 28 sept 2016

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sebastien Canderle como director el 02 jun 2016

    2 páginasTM01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 mar 2016

    13 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 mar 2015

    13 páginas4.68

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:block transfer order - replacement of liquidator
    47 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Informe de progreso del administrador hasta 28 mar 2014

    14 páginas2.24B

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 04 oct 2013

    14 páginas2.24B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    6 páginas2.16B

    Declaración de la propuesta del administrador

    31 páginas2.17B

    ¿Quiénes son los directivos de BRANDSPACE GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DE YOUNG, Michelle Anna-Lisa
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandBritish140102770001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Secretario
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    British102300760001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Secretario corporativo
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ALLNER, Christopher Charles
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Childs Farm
    Director
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Childs Farm
    EnglandBritish78206300001
    BERGIN, Joseph Damien
    Springwood House
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    Springwood House
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritish113935400001
    CANDERLE, Sebastien
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandFrench124282690001
    FAY, Sean Ernan
    7th Floor South
    11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Artillery House
    England
    Director
    7th Floor South
    11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Artillery House
    England
    United KingdomIrish84925400001
    HUGHES, Stephan Michael
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    Director
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish95176800002
    JAQUES, Richard Charles
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish56356980006
    JONES, Neil Henry
    Richmond Hill Court
    TW10 6BG Richmond
    98
    Surrey
    Director
    Richmond Hill Court
    TW10 6BG Richmond
    98
    Surrey
    United KingdomBritish139632430001
    KEILLER, Andrew James
    Harlands Road
    RH16 1LZ Haywards Heath
    95
    West Sussex
    Director
    Harlands Road
    RH16 1LZ Haywards Heath
    95
    West Sussex
    United KingdomBritish172132420001
    LANE, Damien John Patrick
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    Director
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    EnglandEnglish158036110001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Director
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish102300760001
    RAVILIOUS, Greg William Frederick
    Furzefield Avenue
    TN3 0LD Speldhurst
    Ridge House
    Kent
    Director
    Furzefield Avenue
    TN3 0LD Speldhurst
    Ridge House
    Kent
    United KingdomBritish130854210001
    SOANES, Paul Henry
    Sparrow Row
    GU24 8TA Chobham
    Woodside
    Surrey
    Director
    Sparrow Row
    GU24 8TA Chobham
    Woodside
    Surrey
    EnglandBritish68377030007
    SOAR, Guy Jason
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    Director
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    United KingdomBritish96671300002
    SPOONER, Julian Robert Archer
    Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    301
    Surrey
    Director
    Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    301
    Surrey
    EnglandBritish117770880001
    TAYLOR, Richard David
    Lyndon Cottage
    York Road
    LS25 5JW Burton Salmon
    North Yorkshire
    Director
    Lyndon Cottage
    York Road
    LS25 5JW Burton Salmon
    North Yorkshire
    United KingdomBritish123754500001
    VINSON, Jane Elizabeth
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    Director
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish146632890001
    WADE, Roy
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    Director
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    British131852890001
    WRIGHT, Richard Alan
    9 Belsize Mews
    Hampstead
    NW3 5AT London
    Director
    9 Belsize Mews
    Hampstead
    NW3 5AT London
    United KingdomBritish80470950001
    COBBETTS (DIRECTOR) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Director corporativo
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    107196800001

    ¿Tiene BRANDSPACE GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 jun 2010
    Entregado el 08 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Transacciones
    • 08 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 02 nov 2009
    Entregado el 13 nov 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 17 nov 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Creado el 14 jul 2009
    Entregado el 31 jul 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Octopus Investments Limited
    Transacciones
    • 31 jul 2009Registro de un cargo (395)
    Mortgage of a life policy
    Creado el 12 ago 2008
    Entregado el 14 ago 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    P/No L0198163613, argon scottish equitable, life cover £500,000, date 31/07/08, life assured paul soanes see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ago 2008Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities
    Creado el 30 abr 2008
    Entregado el 07 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Life assured stephan hughes zurich assurance limited policy number 1827-62L-dhs lifestyle benefit: £1,000,000 life cover: £2,000,000 all bonuses all rights and interests see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities
    Creado el 30 abr 2008
    Entregado el 07 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Life assured guy soar zurich assurance limited policy number 1845-62L-dhs lifestyle benefit: £500,000 life cover: £1,000,000 all bonuses all rights and interests see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 30 abr 2008
    Entregado el 07 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 30 abr 2008
    Entregado el 07 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 30 abr 2008
    Entregado el 07 may 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transacciones
    • 07 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2008
    Debenture
    Creado el 28 nov 2007
    Entregado el 11 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 11 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of policy
    Creado el 28 nov 2007
    Entregado el 11 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The policy being dated 1 july 2007 p/no 1845-62L-dhs with zurich assurance limited on the life of guy jason soar in the sum of £1,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 11 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of policy
    Creado el 28 nov 2007
    Entregado el 11 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The policy dated 1 july 2007 p/no 1827-62L-dhs with zurich assurance limited on the life of stephen michael hughes in the sum of £2,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 11 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 30 abr 2007
    Entregado el 11 may 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Octopus Investments Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 11 may 2007Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene BRANDSPACE GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 abr 2013Inicio de la administración
    28 mar 2014Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    2
    FechaTipo
    28 mar 2014Inicio de la liquidación
    16 ene 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Liquidador propuesto
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Liquidador propuesto
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Neville Side
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0