ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED

ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05976139
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Henwood House
    Henwood
    TN24 8DH Ashford
    Kent
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SWALLOW WESTGATE LIMITED24 oct 200624 oct 2006

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 oct 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Shaun Rigby Waitt como secretario el 10 may 2018

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Laurence John Waitt como secretario el 10 may 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Shaun Rigby Waitt como director el 10 may 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 24 oct 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Camburgh House 27 New Dover Road Canterbury Kent CT1 3DN a Henwood House Henwood Ashford Kent TN24 8DH el 03 nov 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 28 oct 2016

    3 páginasAA

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Declaración de confirmación presentada el 24 oct 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Huw Daniel Reynolds como director el 31 dic 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Joseph Showler como director el 31 dic 2016

    3 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Anthony Coombes como director el 31 dic 2016

    2 páginasTM01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 28 oct 2015

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 nov 2015

    Estado de capital el 16 nov 2015

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Shaun Rigby Waitt el 30 abr 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 28 oct 2014

    4 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 29 oct 2014 au 28 oct 2014

    1 páginasAA01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 29 oct 2013

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 nov 2014

    Estado de capital el 20 nov 2014

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Registro de la carga 059761390006, creada el 28 ago 2014

    17 páginasMR01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 oct 2013 au 29 oct 2013

    1 páginasAA01

    Cambio de datos del secretario Shaun Rigby Waitt el 14 dic 2013

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Shaun Rigby Waitt el 14 dic 2013

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WAITT, Laurence John
    Henwood
    TN24 8DH Ashford
    Henwood House
    Kent
    England
    Secretario
    Henwood
    TN24 8DH Ashford
    Henwood House
    Kent
    England
    250451410001
    WAITT, Laurence John
    Parsonage Offices
    Nackington
    CT4 7AD Canterbury
    Suite East
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Parsonage Offices
    Nackington
    CT4 7AD Canterbury
    Suite East
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director97725530003
    WAITT, Shaun Rigby
    Henwood
    TN24 8DH Ashford
    Henwood House
    Kent
    England
    Secretario
    Henwood
    TN24 8DH Ashford
    Henwood House
    Kent
    England
    British92090580002
    SDG SECRETARIES LIMITED
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    Secretario designado corporativo
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    900028430001
    COOMBES, John Anthony
    Canterbury Road
    Wingham
    CT3 1BB Canterbury
    Old Forge House
    Kent
    Director
    Canterbury Road
    Wingham
    CT3 1BB Canterbury
    Old Forge House
    Kent
    EnglandBritishSurveyor4538520006
    REYNOLDS, Huw Daniel
    Harbour Street
    CT5 1AQ Whitstable
    11a
    Kent
    Director
    Harbour Street
    CT5 1AQ Whitstable
    11a
    Kent
    United KingdomBritishCompany Administrator50030390002
    SHOWLER, John Joseph
    Sextries Farm Church Lane
    Nackington Village
    CT4 7AF Canterbury
    The Well House
    Kent
    Director
    Sextries Farm Church Lane
    Nackington Village
    CT4 7AF Canterbury
    The Well House
    Kent
    United KingdomBritishTown Planner4856240003
    WAITT, Shaun Rigby
    Henwood
    TN24 8DH Ashford
    Henwood House
    Kent
    England
    Director
    Henwood
    TN24 8DH Ashford
    Henwood House
    Kent
    England
    United KingdomBritishDeveloper92090580007
    SDG REGISTRARS LIMITED
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    Director designado corporativo
    41 Chalton Street
    NW1 1JD London
    900028420001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    CT1 2AJ Canterbury
    Chantry Yard 33b King Street
    Kent
    United Kingdom
    24 oct 2016
    CT1 2AJ Canterbury
    Chantry Yard 33b King Street
    Kent
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03542869
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene ROGATE PROPERTIES (WESTGATE-ON-SEA) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 28 ago 2014
    Entregado el 04 sept 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    Units 3 6 & 8, 85 sea road westgate-on-sea kent t/no. K706137. 5 marilyn court, 73 sea road westgate-on-sea kent t/no. K706137.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 04 sept 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 03 oct 2013
    Entregado el 18 oct 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    5 marilyn court sea road westgate-on-sea kent. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 18 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    Mortgage
    Creado el 31 ago 2010
    Entregado el 04 sept 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a st cecilia's 83 sea road westgate on sea kent t/no K706137 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 04 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 08 jul 2010
    Entregado el 13 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    Legal mortgage
    Creado el 04 dic 2006
    Entregado el 13 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    83 sea road westgate on sea kent t/no k 706137. assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 13 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 17 nov 2006
    Entregado el 25 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 25 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0