KBC CHISWICK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKBC CHISWICK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 05992192
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KBC CHISWICK LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra KBC CHISWICK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    268 Bath Road
    SL1 4DX Slough
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KBC CHISWICK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para KBC CHISWICK LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KBC CHISWICK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Nombramiento de Mr Peter David Edward Gibson como director el 10 abr 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard Morris como director el 10 abr 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Marie Elizabeth Edwards como secretario el 10 abr 2015

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Lyric Square London W6 0NB England a 268 Bath Road Slough SL1 4DX el 22 abr 2015

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Michael James Kingshott como director el 10 abr 2015

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    2 páginasMR04

    Domicilio social registrado cambiado de 22 Long Acre London WC2E 9LY a 268 Bath Road Slough SL1 4DX el 26 nov 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 08 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 nov 2014

    Estado de capital el 20 nov 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 22 Long Acre London WC2E 9LY United Kingdom a 20 Hanover Square London W1S 1JY

    1 páginasAD02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    20 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Marie Elizabeth Edwards como secretario el 18 dic 2013

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Paul Alexander como secretario el 18 dic 2013

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 08 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Serviced Office Group 22 Long Acre London WC2E 9LY England el 04 dic 2013

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Paul Alexander como director el 17 oct 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Alan Douglas Pepper como director el 17 oct 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Alexander como secretario el 17 oct 2013

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Elizabeth Jane Scannell como director el 17 oct 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Jane Scannell como secretario el 17 oct 2013

    1 páginasTM02

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Restatement agreement 07/08/2013
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de KBC CHISWICK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ALEXANDER, Paul Andrew
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Director
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish97550550001
    GIBSON, Peter David Edward
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Director
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Northern IrelandBritish139640170001
    MORRIS, Richard
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Director
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish190653350001
    PEPPER, Alan Douglas
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Director
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish98245120002
    ALEXANDER, Paul
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Secretario
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    183163800001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Secretario
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    British73690140002
    EDWARDS, Marie Elizabeth
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    Secretario
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    185429750001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Secretario
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    Secretario
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    152617650002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Director
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish73690140002
    CORPET, Antoine
    Limburg Road
    SW11 1HB London
    36
    England
    Director
    Limburg Road
    SW11 1HB London
    36
    England
    French131276650001
    HILL, Nicholas Mark Lalor
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    Director
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    United KingdomBritish76547250001
    KINGSHOTT, Michael James
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    Director
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    EnglandBritish83713020002
    PETRIE, Roderick Mckenzie
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    Director
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    ScotlandBritish1246700004
    ROWBOTTOM, Alex James
    Tintagel Gardens
    SE22 8HS London
    1
    United Kingdom
    Director
    Tintagel Gardens
    SE22 8HS London
    1
    United Kingdom
    British135706810001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Director
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    Director
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    EnglandBritish154659960001
    TASCHLER, Jeffery
    18 Leonard St
    NY 10013 New York
    Apartment 2c
    Usa
    Director
    18 Leonard St
    NY 10013 New York
    Apartment 2c
    Usa
    United States135708370001
    WAKELIN, James David
    38 Almeric Road
    Battersea
    SW11 1HL London
    Director
    38 Almeric Road
    Battersea
    SW11 1HL London
    British92221010001
    WASHINGTON, Robert Francis
    133 Stormont Road
    SW11 5EJ London
    Director
    133 Stormont Road
    SW11 5EJ London
    Australian120776550001

    ¿Tiene KBC CHISWICK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 22 nov 2012
    Entregado el 29 nov 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Turnham green terrace, london t/no AGL193916. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 14 may 2013Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 16 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 nov 2012
    Entregado el 29 nov 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Turnham green terrace, london t/no AGL193916 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 14 may 2013Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 16 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 22 nov 2012
    Entregado el 28 nov 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01.
    Personas con derecho
    • West Register Number 2 Limited
    Transacciones
    • 28 nov 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 14 may 2013Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 16 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of substituted security relating to legal charge dated 9 may 2007
    Creado el 20 oct 2008
    Entregado el 22 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Upperparts gable house 18-28 turnham green terrace london t/no AGL190117 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 24 jun 2008
    Entregado el 02 jul 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property more fully detailed within the deed of variation of lease of premises at upper parts of gable house, 18-22 turnham green terrace, london fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 09 may 2007
    Entregado el 10 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a upper parts of gable house 18-28 turnham green terrace london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 18 dic 2006
    Entregado el 21 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 06 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0