KBC CHISWICK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KBC CHISWICK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 05992192 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KBC CHISWICK LIMITED?
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra KBC CHISWICK LIMITED?
| Dirección de la sede social | 268 Bath Road SL1 4DX Slough England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KBC CHISWICK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para KBC CHISWICK LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KBC CHISWICK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter David Edward Gibson como director el 10 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Morris como director el 10 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Marie Elizabeth Edwards como secretario el 10 abr 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Lyric Square London W6 0NB England a 268 Bath Road Slough SL1 4DX el 22 abr 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael James Kingshott como director el 10 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 22 Long Acre London WC2E 9LY a 268 Bath Road Slough SL1 4DX el 26 nov 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 22 Long Acre London WC2E 9LY United Kingdom a 20 Hanover Square London W1S 1JY | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Marie Elizabeth Edwards como secretario el 18 dic 2013 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Alexander como secretario el 18 dic 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Serviced Office Group 22 Long Acre London WC2E 9LY England el 04 dic 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Alexander como director el 17 oct 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alan Douglas Pepper como director el 17 oct 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Alexander como secretario el 17 oct 2013 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Jane Scannell como director el 17 oct 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Jane Scannell como secretario el 17 oct 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KBC CHISWICK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER, Paul Andrew | Director | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 97550550001 | |||||
| GIBSON, Peter David Edward | Director | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | Northern Ireland | British | 139640170001 | |||||
| MORRIS, Richard | Director | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 190653350001 | |||||
| PEPPER, Alan Douglas | Director | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 98245120002 | |||||
| ALEXANDER, Paul | Secretario | Long Acre WC2E 9LY London 22 England | 183163800001 | |||||||
| CLAGUE, Stephen James Taylor | Secretario | 72 Shinfield Road RG2 7DA Reading Berkshire | British | 73690140002 | ||||||
| EDWARDS, Marie Elizabeth | Secretario | Lyric Square W6 0NB London 1 England | 185429750001 | |||||||
| SAVANI, Iqbal | Secretario | 18 Berry Hill HA7 4XS Stanmore Middlesex | British | 96895020001 | ||||||
| SCANNELL, Elizabeth Jane | Secretario | Long Acre WC2E 9LY London 22 | 152617650002 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CLAGUE, Stephen James Taylor | Director | 72 Shinfield Road RG2 7DA Reading Berkshire | United Kingdom | British | 73690140002 | |||||
| CORPET, Antoine | Director | Limburg Road SW11 1HB London 36 England | French | 131276650001 | ||||||
| HILL, Nicholas Mark Lalor | Director | 36 Hazlewell Road SW15 6LR London | United Kingdom | British | 76547250001 | |||||
| KINGSHOTT, Michael James | Director | Long Acre WC2E 9LY London 22 United Kingdom | England | British | 83713020002 | |||||
| PETRIE, Roderick Mckenzie | Director | Clashfarquhar 37 Kings Road EH32 0NN Longniddry East Lothian | Scotland | British | 1246700004 | |||||
| ROWBOTTOM, Alex James | Director | Tintagel Gardens SE22 8HS London 1 United Kingdom | British | 135706810001 | ||||||
| SAVANI, Iqbal | Director | 18 Berry Hill HA7 4XS Stanmore Middlesex | British | 96895020001 | ||||||
| SCANNELL, Elizabeth Jane | Director | Long Acre WC2E 9LY London 22 United Kingdom | England | British | 154659960001 | |||||
| TASCHLER, Jeffery | Director | 18 Leonard St NY 10013 New York Apartment 2c Usa | United States | 135708370001 | ||||||
| WAKELIN, James David | Director | 38 Almeric Road Battersea SW11 1HL London | British | 92221010001 | ||||||
| WASHINGTON, Robert Francis | Director | 133 Stormont Road SW11 5EJ London | Australian | 120776550001 |
¿Tiene KBC CHISWICK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 22 nov 2012 Entregado el 29 nov 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Turnham green terrace, london t/no AGL193916. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 22 nov 2012 Entregado el 29 nov 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Turnham green terrace, london t/no AGL193916 see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 22 nov 2012 Entregado el 28 nov 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of substituted security relating to legal charge dated 9 may 2007 | Creado el 20 oct 2008 Entregado el 22 oct 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Upperparts gable house 18-28 turnham green terrace london t/no AGL190117 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 24 jun 2008 Entregado el 02 jul 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The l/h property more fully detailed within the deed of variation of lease of premises at upper parts of gable house, 18-22 turnham green terrace, london fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 09 may 2007 Entregado el 10 may 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a upper parts of gable house 18-28 turnham green terrace london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 18 dic 2006 Entregado el 21 dic 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0