LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 06025239 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED?
| Dirección de la sede social | Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby North East Lincolnshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HACKREMCO (NO. 2439) LIMITED | 11 dic 2006 | 11 dic 2006 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 jun 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 dic 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr John Philip Madden como director el 08 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de William John Showalter como director el 11 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ross House Wickham Road North East Lincolnshire Grimsby DN31 3SW England a Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ el 08 nov 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2018 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 10 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 03 jul 2019
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga 060252390003 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited el 02 ene 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 dic 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Karen Jeanette Noakes como director el 01 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 2SW a Ross House Wickham Road North East Lincolnshire Grimsby DN31 3SW el 21 dic 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2015 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Guy Nicholas Anthony Faller como director el 29 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Karen Jeanette Noakes como director el 29 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Frank Parker como director el 31 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House North East Lincolnshire United Kingdom |
| 75197930001 | ||||||||||
| MADDEN, John Philip | Director | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Wilkin Chapman Llp, Cartergate House North East Lincolnshire England | England | British | 264245380001 | |||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Secretario | Mill Lane Legbourne LN11 8LT Louth Allt-Nam-Breac Lincolnshire | British | 129100490001 | ||||||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Director | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| CAMPBELL, Christopher | Director | 74 Coleherne Court Little Boltons SW5 0EF London | American | 109921890001 | ||||||||||
| CANE, James Robert | Director | Chapel House Brigg Road LN7 6PQ South Kelsey Lincolnshire | United Kingdom | British | 104635350001 | |||||||||
| FALLER, Guy Nicholas Anthony | Director | Wickham Road Grimsby DN31 2SW North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 108529830002 | |||||||||
| FITZPATRICK, Seamus Philip | Director | Flat 1 1 Onslow Gardens SW7 3LX London | United Kingdom | Irish | 65991000003 | |||||||||
| FORBES, Hamish Drummond | Director | Wickham Road Grimsby DN31 2SW North East Lincolnshire | England | British | 66295550001 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Director | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Director | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| NOAKES, Karen Jeanette | Director | Wickham Road North East Lincolnshire DN31 3SW Grimsby Ross House England | England | British | 134379900001 | |||||||||
| PARKER, Christopher Frank | Director | Wickham Road Grimsby DN31 2SW North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 66681550001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Director | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| SHOWALTER, William John | Director | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Wilkin Chapman Llp, Cartergate House North East Lincolnshire England | England | American | 178622380001 | |||||||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 11 dic 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene LIGHTHOUSE UKCO 1 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 02 nov 2015 Entregado el 09 nov 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 19 jul 2013 Entregado el 25 jul 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 oct 2008 Entregado el 01 nov 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0