MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 06055271 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD?
| Dirección de la sede social | Suites 7&9 Regency House Miles Gray Road SS14 3FR Basildon England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MORTGAGE AND SURVEYING SERVICES LIMITED | 09 dic 2020 | 09 dic 2020 |
| SDL PROPERTY SERVICES GROUP LIMITED | 03 jul 2017 | 03 jul 2017 |
| SHEPHERD DIRECT LIMITED | 04 jul 2007 | 04 jul 2007 |
| CASTLEGATE 464 LIMITED | 17 ene 2007 | 17 ene 2007 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 04 jun 2026 |
| Última declaraci ón de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 63 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 63 páginas | MA | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 jul 2025
| 7 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Registro de la carga 060552710007, creada el 26 jun 2025 | 42 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed mortgage and surveying services LIMITED\certificate issued on 27/06/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 may 2025 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 30 abr 2025
| 6 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 61 páginas | MA | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 61 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 60 páginas | AA | ||||||||||||||
Cancelación de acciones. Estado de capital el 29 oct 2024
| 9 páginas | SH06 | ||||||||||||||
Compra de acciones propias. | 4 páginas | SH03 | ||||||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Heath Lee Walker como secretario el 17 sept 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Kate Tuck como secretario el 17 sept 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3-4 Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell Nottingham NG9 6RZ a Suites 7&9 Regency House Miles Gray Road Basildon SS14 3FR el 10 jul 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 may 2024 con actualizaciones | 11 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert Martin Clifford el 03 may 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 62 páginas | AA | ||||||||||||||
Registro de la carga 060552710006, creada el 14 sept 2023 | 43 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Cancelación de acciones. Estado de capital el 02 ago 2023
| 12 páginas | SH06 | ||||||||||||||
Compra de acciones propias. | 4 páginas | SH03 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER, Heath Lee | Secretario | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | 327283920001 | |||||||
| BREWSTER, George Pattullo | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | Scotland | British | 67967330002 | |||||
| CLIFFORD, Robert Martin | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 177347450003 | |||||
| FERGUSSON, Ian James | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | Scotland | British | 121573070001 | |||||
| GRATTON, Elizabeth Anne | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 124053200003 | |||||
| GRATTON, Paul Robert | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 47117090005 | |||||
| HICKLING, Christopher Charles | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 193578840001 | |||||
| HICKLING, Julia Ann | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 2439880001 | |||||
| JACKSON, Simon Paul | Director | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | England | British | 128766890001 | |||||
| WALKER, Heath Lee | Director | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | England | British | 174700320001 | |||||
| WARRINER, Stuart Neil | Director | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | England | British | 312196370001 | |||||
| WILLIAMS, Jill Caroline | Director | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | England | British | 248918880002 | |||||
| STALEY, Catherine Sara | Secretario | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | British | 73310800002 | ||||||
| TUCK, Sarah Kate | Secretario | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | 296461780001 | |||||||
| TUCK, Sarah Kate | Secretario | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | 245962390001 | |||||||
| WALDRON, Karen | Secretario | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | 295372000001 | |||||||
| CASTLEGATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Castle Gate NG1 7BJ Nottingham 44 Nottinghamshire | 128872830001 | |||||||
| ANDERTON, Colin James | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 183725480001 | |||||
| BLOOMER, Jonathan William | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 115487540001 | |||||
| DOWNING, Ian | Director | c/o Business Growth Fund Plc Palmer Street SW1H 0AD London 21 United Kingdom | England | British | 285024490001 | |||||
| FERGUSSON, Ian James | Director | 29 Park Terrace FK8 2JS Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 121573070001 | |||||
| HICKLING, Christopher Charles | Director | Wollaton House Wollaton NG8 2AH Nottingham | England | British | 2439890001 | |||||
| SINGH, Matthew | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 294957230001 | |||||
| SUNNER, Gurinder | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 278764020001 | |||||
| TAMPLIN, Nigel Vernon | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | United Kingdom | British | 188794210001 | |||||
| WALL, Catherine Alison | Director | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 37354000004 | |||||
| CASTLEGATE DIRECTORS LIMITED | Director corporativo | Castle Gate NG1 7BJ Nottingham 44 Nottinghamshire | 128874440001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bgf Investment Management Limited | 01 may 2023 | York Buildings WC2N 6JU London 13-15 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Bgf Gp Limited | 01 oct 2017 | York Buildings WC2N 6JU London 13-15 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Business Growth Fund Plc | 06 abr 2016 | York Buildings WC2N 6JU London 13-15 York Buildings England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| J&E Nominees Limited | 06 abr 2016 | Albert Square, Meadowside DD1 1XA Dundee 13 Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0