MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 06055526 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?
- Actividades de sociedades holding de producción (64202) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?
Dirección de la sede social | Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
WHOLE ACCORD LIMITED | 17 ene 2007 | 17 ene 2007 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 17 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jul 2022 | 18 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Mill (Facility) Limited 11-14 Windmill Street London W1T 2JG England a Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU el 19 ago 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cessation de Technicolor Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Estado de capital el 22 feb 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Marshall Hibbins como director el 31 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Hunter Simon como director el 01 ago 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Marshall Hibbins el 01 ene 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robin Richard Shenfield como director el 06 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hunter Simon como secretario el 22 oct 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hunter Simon como director el 22 oct 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robin Richard Shenfield el 03 ene 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON, Hunter | Director | York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited 22 | United States | American | General Counsel | 243402930003 | ||||
DAWSON, Rodney | Secretario | Chapel Cottage 2 High Street Great Linford MK14 5AX Milton Keynes Buckinghamshire | British | 26790340001 | ||||||
MOURGUE D'ALGUE, Bruno | Secretario | 19 Melrose Gardens W6 7RN London | French | Private Equity Professional | 142227550002 | |||||
SIMON, Hunter | Secretario | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill (Facility) Limited England | 246495950001 | |||||||
SMITH, Jamie | Secretario | Windmill Street W1T 2JG London The Mill England | 202761080001 | |||||||
WOLFSON, Michael | Secretario | 11-14, Windmill Street W1T 2JG London Charlotte House England | British | 165123610001 | ||||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
FITZGERALD, David James | Director | 55 Ridgway Place SW19 4SP London | England | Irish | Managing Director | 141363290001 | ||||
HIBBINS, Simon Marshall | Director | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill (Facility) Limited England | United Kingdom | Australian | Senior Vice President | 169524520004 | ||||
HODGES, Christopher James | Director | 69 Portnall Road W9 3BB London | United Kingdom | British | Private Equity Fund Manager | 116569340001 | ||||
JOSEPH, Patrick | Director | Vancouver Lodge High Street MK18 5JX Dadford Buckinghamshire | United Kingdom | British | Production Manager | 60554580002 | ||||
MITCHELL, Craig David | Director | Brambleside Brays Close HP6 5RZ Hyde Heath Buckinghamshire | England | Irish | Accountant | 77799780001 | ||||
MOURGUE D'ALGUE, Bruno | Director | 19 Melrose Gardens W6 7RN London | England | French | Private Equity Professional | 142227550002 | ||||
SHENFIELD, Robin Richard | Director | 17a Highbury Terrace Mews N5 1UT London | England | British | Chief Executive Officer | 46137000003 | ||||
SIMON, Hunter | Director | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill (Facility) Limited England | United States | American | General Counsel | 243402930002 | ||||
SMITH, Jamie Alexander | Director | 11-14 Windmill Street W1T 2JG London The Mill (Facility) Limited England | United Kingdom | British | General Counsel | 236410990001 | ||||
WOLFSON, Michael Barry | Director | 4 Abbey View WD7 8LT Radlett Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 119783620001 | ||||
YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technicolor Holdings Limited | 15 sept 2016 | Great Queen Street Covent Garden WC2B 5AH London 16 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mill Acquisitions 1 Limited | 15 sept 2016 | Windmill Street W1T 2JG London 11-14 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 15 dic 2014 Entregado el 19 dic 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 15 dic 2014 Entregado el 19 dic 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Pledge agreement | Creado el 31 may 2011 Entregado el 09 jun 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company, the borrowers, the guarantors and/or any other obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All of the right title and interest in, to and under all of the following, all equity interests, 1 share of $0.01 par value common stock, 999 shares of $0.01 par value common stock, all debt interests, all payments of principal and interest, dividends, all rights and privileges. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of accession and charge | Creado el 06 may 2011 Entregado el 19 may 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 02 feb 2007 Entregado el 14 feb 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0