MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED

MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMILL ACQUISITIONS 2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 06055526
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?

    • Actividades de sociedades holding de producción (64202) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Resolve Advisory Limited 22
    York Buildings
    WC2N 6JU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WHOLE ACCORD LIMITED17 ene 200717 ene 2007

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    17 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jul 2022

    18 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de The Mill (Facility) Limited 11-14 Windmill Street London W1T 2JG England a Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU el 19 ago 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 jul 2021

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cessation de Technicolor Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2021

    1 páginasPSC07

    Estado de capital el 22 feb 2021

    • Capital: GBP 0.01
    3 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Cese del nombramiento de Simon Marshall Hibbins como director el 31 jul 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Hunter Simon como director el 01 ago 2020

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 ene 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Simon Marshall Hibbins el 01 ene 2018

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Robin Richard Shenfield como director el 06 nov 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Hunter Simon como secretario el 22 oct 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Hunter Simon como director el 22 oct 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    20 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Robin Richard Shenfield el 03 ene 2018

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SIMON, Hunter
    York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited 22
    Director
    York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited 22
    United StatesAmericanGeneral Counsel243402930003
    DAWSON, Rodney
    Chapel Cottage 2 High Street
    Great Linford
    MK14 5AX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario
    Chapel Cottage 2 High Street
    Great Linford
    MK14 5AX Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British26790340001
    MOURGUE D'ALGUE, Bruno
    19 Melrose Gardens
    W6 7RN London
    Secretario
    19 Melrose Gardens
    W6 7RN London
    FrenchPrivate Equity Professional142227550002
    SIMON, Hunter
    11-14 Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill (Facility) Limited
    England
    Secretario
    11-14 Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill (Facility) Limited
    England
    246495950001
    SMITH, Jamie
    Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill
    England
    Secretario
    Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill
    England
    202761080001
    WOLFSON, Michael
    11-14, Windmill Street
    W1T 2JG London
    Charlotte House
    England
    Secretario
    11-14, Windmill Street
    W1T 2JG London
    Charlotte House
    England
    British165123610001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    FITZGERALD, David James
    55 Ridgway Place
    SW19 4SP London
    Director
    55 Ridgway Place
    SW19 4SP London
    EnglandIrishManaging Director141363290001
    HIBBINS, Simon Marshall
    11-14 Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill (Facility) Limited
    England
    Director
    11-14 Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill (Facility) Limited
    England
    United KingdomAustralianSenior Vice President169524520004
    HODGES, Christopher James
    69 Portnall Road
    W9 3BB London
    Director
    69 Portnall Road
    W9 3BB London
    United KingdomBritishPrivate Equity Fund Manager116569340001
    JOSEPH, Patrick
    Vancouver Lodge
    High Street
    MK18 5JX Dadford
    Buckinghamshire
    Director
    Vancouver Lodge
    High Street
    MK18 5JX Dadford
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishProduction Manager60554580002
    MITCHELL, Craig David
    Brambleside
    Brays Close
    HP6 5RZ Hyde Heath
    Buckinghamshire
    Director
    Brambleside
    Brays Close
    HP6 5RZ Hyde Heath
    Buckinghamshire
    EnglandIrishAccountant77799780001
    MOURGUE D'ALGUE, Bruno
    19 Melrose Gardens
    W6 7RN London
    Director
    19 Melrose Gardens
    W6 7RN London
    EnglandFrenchPrivate Equity Professional142227550002
    SHENFIELD, Robin Richard
    17a Highbury Terrace Mews
    N5 1UT London
    Director
    17a Highbury Terrace Mews
    N5 1UT London
    EnglandBritishChief Executive Officer46137000003
    SIMON, Hunter
    11-14 Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill (Facility) Limited
    England
    Director
    11-14 Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill (Facility) Limited
    England
    United StatesAmericanGeneral Counsel243402930002
    SMITH, Jamie Alexander
    11-14 Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill (Facility) Limited
    England
    Director
    11-14 Windmill Street
    W1T 2JG London
    The Mill (Facility) Limited
    England
    United KingdomBritishGeneral Counsel236410990001
    WOLFSON, Michael Barry
    4 Abbey View
    WD7 8LT Radlett
    Hertfordshire
    Director
    4 Abbey View
    WD7 8LT Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant119783620001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Director designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Technicolor Holdings Limited
    Great Queen Street
    Covent Garden
    WC2B 5AH London
    16
    United Kingdom
    15 sept 2016
    Great Queen Street
    Covent Garden
    WC2B 5AH London
    16
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro02270255
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mill Acquisitions 1 Limited
    Windmill Street
    W1T 2JG London
    11-14
    England
    15 sept 2016
    Windmill Street
    W1T 2JG London
    11-14
    England
    No
    Forma jurídicaLimited
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro06055540
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 15 dic 2014
    Entregado el 19 dic 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 19 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    • 06 mar 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 15 dic 2014
    Entregado el 19 dic 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 19 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    • 06 mar 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Pledge agreement
    Creado el 31 may 2011
    Entregado el 09 jun 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company, the borrowers, the guarantors and/or any other obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the right title and interest in, to and under all of the following, all equity interests, 1 share of $0.01 par value common stock, 999 shares of $0.01 par value common stock, all debt interests, all payments of principal and interest, dividends, all rights and privileges. See image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland (As Security Agent)
    Transacciones
    • 09 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 24 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creado el 06 may 2011
    Entregado el 19 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transacciones
    • 19 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 24 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 02 feb 2007
    Entregado el 14 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 14 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene MILL ACQUISITIONS 2 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 jul 2021Inicio de la liquidación
    24 nov 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Profesional
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Profesional
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0