VENICE ANTLER 3 LIMITED

VENICE ANTLER 3 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVENICE ANTLER 3 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 06067357
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VENICE ANTLER 3 LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra VENICE ANTLER 3 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VENICE ANTLER 3 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    POLEGRANGE LIMITED25 ene 200725 ene 2007

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VENICE ANTLER 3 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VENICE ANTLER 3 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A24JEAQZ

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 ene 2013

    Estado de capital el 28 ene 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X20ZDKOA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    19 páginasAA
    A1I7CIPT

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    X11A07MG

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    20 páginasAA
    ASS3AYUZ

    Nombramiento de Mr Matthew Edward Bennison como director

    2 páginasAP01
    XAYEZW5J

    Nombramiento de Mr Matthew Edward Bennison como secretario

    1 páginasAP03
    XAYF6W5R

    Cese del nombramiento de Timothy Doubleday como director

    1 páginasTM01
    XAYDMW55

    Cese del nombramiento de Timothy Doubleday como secretario

    1 páginasTM02
    XAYDFW5Y

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    XKDO5R3H

    Cese del nombramiento de Martin Clarke como director

    2 páginasTM01
    A5H4VPQA

    Nombramiento de Mr Timothy Doubleday como secretario

    3 páginasAP03
    A7QKSPLT

    Cese del nombramiento de Paul Nisbett como director

    2 páginasTM01
    A7D66PLG

    Cese del nombramiento de Sally Flanagan como director

    2 páginasTM01
    A7QJ9PL9

    Nombramiento de Mr Timothy John Doubleday como director

    3 páginasAP01
    A7QM8PLB

    Cese del nombramiento de Geraldine Gallagher como secretario

    2 páginasTM02
    A7D47PLF

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    18 páginasAA
    A90NIPJW

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    XRXPOH6L

    Cambio de datos del director Gail Susan Hunter el 25 ene 2010

    2 páginasCH01
    XRXPNH6K

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    14 páginasAA
    A039WB6Z

    legacy

    4 páginas363a
    XLR3G6VT

    legacy

    1 páginas287
    XJXDP6O9

    legacy

    3 páginas288a
    AUB6F2AC

    ¿Quiénes son los directivos de VENICE ANTLER 3 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161873750001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHuman Resources Director89557480002
    TROY, Anthony Gerrard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrishDirector104500230001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156133610001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Secretario
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BURRELL, James
    79 Disraeli Road
    SW15 2DR London
    Director
    79 Disraeli Road
    SW15 2DR London
    BritishInvestment Executive115775330001
    CLARKE, Martin Andrew, Dr
    35 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Uk
    Director
    35 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Uk
    United KingdomBritishPartner At Private Equity Hous121053560001
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Director
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritishDirector124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer91011320001
    FLANAGAN, Sally Deborah
    10 Cobden Hill
    WD7 7JR Radlett
    Hertfordshire
    Director
    10 Cobden Hill
    WD7 7JR Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishInvestment Executive116577710001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Director
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritishSolicitor147682410001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Director
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director132613500001
    PUDGE, David John
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Director
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritishSolicitor162620820001

    ¿Tiene VENICE ANTLER 3 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Share charge
    Creado el 11 oct 2007
    Entregado el 24 oct 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the subsidiary shares being 1 ordinary share in venice regal limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 oct 2007Registro de un cargo (395)
    A share charge
    Creado el 25 may 2007
    Entregado el 30 may 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All subsidiary shares and all corresponding distribution rights and floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 may 2007Registro de un cargo (395)
    Share charge
    Creado el 04 abr 2007
    Entregado el 16 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the subsidiary shares means venice antler 4 limited, 100 ordinary shares, venice owl limited, 100 ordinary shares and all corresponding distribution rights means all dividends, distributions and other income. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 07 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0