LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 06137133 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
PTCS 6155A LIMITED | 05 mar 2007 | 05 mar 2007 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Morton Fraser Llp St Martins House 16 st Martins Le Grand London EC1A 4EN a 1 More London Place London SE1 2AF el 08 ene 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de David Mel Zuydam como director el 01 ene 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2018 au 30 jun 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Mel Zuydam como director el 11 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Katerina Brown como director el 04 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Scott Leitch Mackenzie como director el 30 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew William Lee como director el 05 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Alan Walters como director el 05 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 13 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 1 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 14 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mark Alan Walters como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mark Alan Walters como director el 14 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Nagle como director el 14 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew William Lee como director el 14 dic 2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Huw Griffiths como director el 14 dic 2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 2 Lister Square Quartermile Two EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Scotland |
| 95512800001 | ||||||||||
GRIFFITHS, David Huw | Director | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | Coo | 177733400003 | ||||||||
ATTERBURY, Karen Lorraine | Secretario | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201246720001 | |||||||||||
BISSET, Graham Ferguson | Secretario | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194566850001 | |||||||||||
CALDER, Samantha Jane | Secretario | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | British | 75830790003 | ||||||||||
HULLEY, Christine Wyn | Secretario | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 35745290002 | ||||||||||
LONG, Jacqueline | Secretario | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204213410001 | |||||||||||
OLDROYD, Elizabeth Alexandra | Secretario | 19 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GF Bath | British | Solicitor | 98205520001 | |||||||||
AIKMAN, Elizabeth Jane | Director | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | Finance Director | 294355310001 | ||||||||
BOYD, Gordon Alexander | Director | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | Chief Financial Officer | 148856600001 | ||||||||
BROWN, Katerina | Director | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | Scotland | British | Accountant | 232165890001 | ||||||||
BUXTON, Tony Martyn | Director | Oaklands Somerford Road GL7 1FA Cirencester 33 Glos United Kingdom | England | British | Gne Manager - Business Develop | 132588550002 | ||||||||
FITZSIMMONS, David Stephen | Director | Hammer Tower Penshurst TN11 8HZ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | Ceo | 109928450001 | ||||||||
GIBBINS, Stewart Charles | Director | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Operations Director | 148918290002 | ||||||||
GREGSON, Paul Jonathan | Director | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | Human Resources Director | 154908310001 | ||||||||
HARDMAN, Steven Neville | Director | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | Uk | British | Solicitor | 93743250007 | ||||||||
HEWSON, John Francis | Director | 30 Bedford Street London WC2E 9ED | United Kingdom | British | Development Director | 120308140001 | ||||||||
HINTON, Thomas Edward | Director | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | England | British | Chief Finance Officer | 238940970001 | ||||||||
HULLEY, Christine Wyn | Director | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | Accountant | 35745290002 | |||||||||
HULLEY, Stephen Paul | Director | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | Engineer | 58163070002 | |||||||||
LEE, Andrew William | Director | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | Energy Finance Professional | 87527870001 | ||||||||
MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Director | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | Belgian | Director | 125748990002 | ||||||||
MACKENZIE, Scott Leitch | Director | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | Scotland | British | Director | 277478140001 | ||||||||
NAGLE, Michael | Director | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | Company Director | 29436380007 | ||||||||
PICKERING, Stephen Shane | Director | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | England | British | Director Of Operations | 198076630001 | ||||||||
QUINLAN, Rory John | Director | Flat 12 25 Queen's Gate Gardens South Kensington SW7 5RP London | Australian | Finance Director | 113941780001 | |||||||||
ROUND, Richard Calvin | Director | Elimbriar 8 Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Beds | Uk | British | Finance Director | 108158250002 | ||||||||
WALTERS, Mark Alan | Director | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | Chartered Accountant | 317548840001 | ||||||||
ZUYDAM, David Mel | Director | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | Director | 259635370001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infinis Wind Holdings Limited | 06 abr 2016 | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 15 dic 2017 Entregado el 29 dic 2017 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 09 oct 2013 Entregado el 11 oct 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 19 nov 2007 Entregado el 26 nov 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0