CONSORT HEALTHCARE (TAMESIDE) PLC
Visión general
| Nombre de la empresa | CONSORT HEALTHCARE (TAMESIDE) PLC |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
| Número de empresa | 06165353 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CONSORT HEALTHCARE (TAMESIDE) PLC?
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CONSORT HEALTHCARE (TAMESIDE) PLC?
| Dirección de la sede social | 8 White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley Kent United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CONSORT HEALTHCARE (TAMESIDE) PLC?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CONSORT HEALTHCARE (TAMESIDE) PLC?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 15 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 29 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 15 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CONSORT HEALTHCARE (TAMESIDE) PLC?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2025 au 31 dic 2025 | 1 páginas | AA01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Gareth Michael Williams como director el 30 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Infraconsult Management Services Limited como director el 30 ago 2024 | 2 páginas | AP02 | ||
Cese del nombramiento de William Edward Morris como director el 30 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Stephanie Ann Exell como director el 30 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2023 au 30 jun 2024 | 1 páginas | AA01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de , C/O Albany Spc Services Ltd 3-5 Charlotte Street, Manchester, M1 4HB, England a 8 White Oak Square London Road Swanley Kent BR8 7AG el 10 may 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Vercity Management Services Limited como secretario el 07 may 2024 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Janet Denise Whitehead como secretario el 15 abr 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Geoffrey David Holden como director el 31 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr William Edward Morris el 22 ago 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr William Edward Morris como director el 10 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 29 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de David Alexander John Foot como director el 09 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Renuncia del auditor | 2 páginas | AUD | ||
Nombramiento de Mrs Janet Denise Whitehead como secretario el 22 sept 2021 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Asset Management Solutions Limited como secretario el 22 sept 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de , Second Floor 46 Charles Street, Cardiff, CF10 2GE, Wales a 8 White Oak Square London Road Swanley Kent BR8 7AG el 21 sept 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 27 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CONSORT HEALTHCARE (TAMESIDE) PLC?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERCITY MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent United Kingdom |
| 183851690004 | ||||||||||
| WILLIAMS, Gareth Michael | Director | White Oak Square London Road BR8 7AG Swanley 8 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 326673140001 | |||||||||
| INFRACONSULT MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director corporativo | 1 Blatchington Road, BN3 3YP Hove C/O Brennan Herriott & Co East Sussex United Kingdom |
| 326640030001 | ||||||||||
| BLISS, Daniel James | Secretario | 6th Floor 350 Euston Road Regents Place NW1 3AX London | 175465870001 | |||||||||||
| BLISS, Daniel James | Secretario | Rockbourne Way Ingleby Barwick TS17 5LH Stockton-On-Tees 18 Cleveland | British | 140134950001 | ||||||||||
| JENNAWAY, Simon | Secretario | 16 Moorfields Close TW18 3LU Staines Middlesex | British | 74352620001 | ||||||||||
| MARKANDAY, Nikhil | Secretario | Flat 4 24 Parkhill Road NW3 2YP London | British | 121309060001 | ||||||||||
| PENNYCUICK, James Andrew | Secretario | Forth Banks NE1 3PA Newcastle Upon Tyne 8th Floor West One Tyne And Wear | British | 153666880001 | ||||||||||
| WHITEHEAD, Janet Denise | Secretario | 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd England | 287523590001 | |||||||||||
| WYLLIE, Alison | Secretario | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | British | 107811220001 | ||||||||||
| ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | Secretario corporativo | 46 Charles Street CF10 2GE Cardiff Second Floor Wales |
| 114724080001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario corporativo | 1 Mitchell Lane BS1 6BU Bristol | 111451340001 | |||||||||||
| APPUHAMY, Ion Francis | Director | 72 Staunton Road KT2 5TL Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 110636430001 | |||||||||
| BESWETHERICK, Elizabeth Jo | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London Infrared Capital Partners Ltd England | England | British | 246894680001 | |||||||||
| COOPER, Phillip John | Director | c/o Hsbc Specialist Fund Management Ltd Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 116775310001 | |||||||||
| ENTRACT, Jonathan Mark | Director | 21 Weybridge Park KT13 8SQ Weybridge Surrey | England | British | 86046470002 | |||||||||
| EXELL, Stephanie Ann | Director | Level 7 One Bartholomew Close, Barts Sq EC1A 7BL London Infrared Capital Partners Ltd England | United Kingdom | British | 261406680001 | |||||||||
| FOOT, David Alexander John, Mr. | Director | Level 7 One Bartholomew Close, Barts Sq EC1A 7BL London Infrared Capital Partners Ltd England | England | British | 245579910001 | |||||||||
| HALL SMITH, James Edward | Director | Abbey Oak Wherwell SP11 7HY Andover Hampshire | United Kingdom | British | 86362140001 | |||||||||
| HOLDEN, Mark Geoffrey David | Director | Level 7 One Bartholomew Close, Barts Sq EC1A 7BL London Infrared Capital Partners Ltd England | England | British | 170508700001 | |||||||||
| HOLDEN, Mark Geoffrey David | Director | Eden Park Road SK8 6RG Cheadle Hulme 7 Cheshire | England | British | 170508700001 | |||||||||
| LELEW, Nigel | Director | 6th Floor 350 Euston Road Regents Place NW1 3AX London | England | British | 147087250001 | |||||||||
| LEWIS, David John | Director | 6th Floor 350 Euston Road Regents Place NW1 3AX London | England | British | 136129100001 | |||||||||
| MORRIS, William Edward | Director | Level 7, One Bartholomew Close EC1A 7BL London Infrared Capital Partners Limited England | United Kingdom | British | 289326600001 | |||||||||
| NEWTON, Robert James | Director | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 England | United Kingdom | British | 295465260001 | |||||||||
| QUAIFE, Geoffrey Alan | Director | 8 Canada Square Fao Hsbc Specialist Fund Management Ltd E14 5HQ London Level 21 | United Kingdom | British | 123048390001 | |||||||||
| ROSS, Michael Melville Brown | Director | Euston Road NW1 3AX London 350 United Kingdom | Uk | British | 114386250001 | |||||||||
| SPENCER, Christopher Loraine | Director | 143 Shooters Hill Road Blackheath SE3 8UQ London | United Kingdom | British | 111123420001 | |||||||||
| THOMPSON, Linda Jayne | Director | Room 1.06 Haslingden Road BB2 3HH Blackburn Park View Offices | United Kingdom | British | 149417060001 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director corporativo | 1 Mitchell Lane BS1 6BU Bristol | 93433510001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Director corporativo | 1 Mitchell Lane BS1 6BU Bristol | 111451340001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CONSORT HEALTHCARE (TAMESIDE) PLC?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consort Healthcare (Tameside) Holdings Limited | 06 abr 2016 | Charles Street CF10 2GE Cardiff 46 Wales | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0