COSTA BEIJING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOSTA BEIJING LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 06190419
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COSTA BEIJING LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra COSTA BEIJING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3 Knaves Beech Business Centre Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    Buckinghamshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COSTA BEIJING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WHITBREAD PUB RESTAURANTS HOLDING COMPANY LIMITED28 mar 200728 mar 2007

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COSTA BEIJING LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COSTA BEIJING LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta03 abr 2026
    Próxima declaración de confirmación vence17 abr 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta03 abr 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COSTA BEIJING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2024

    21 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jonathan Mark Crookall como director el 10 oct 2025

    1 páginasTM01

    Segunda presentación para el nombramiento de Suzanne Werner como secretario

    3 páginasRP04AP03

    Nombramiento de Suzanne Werner como secretario el 30 jun 2025

    3 páginasAP03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    21 jul 2025Clarification A second filed AP03 was registered on 21/07/2025.

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Sunita Savjani como secretario el 29 nov 2024

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023

    22 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Mounsef Otarid el 01 jul 2023

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Adrian Ernest Cook como director el 20 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022

    24 páginasAA

    Nombramiento de Philippe Dirk M. Schaillee como director el 11 abr 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 3 Knaves Beech Business Centre Davies Way Loudwater High Wycombe HP10 9QR

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Mr Mounsef Otarid como director el 13 feb 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Adrian Ernest Cook como director el 13 feb 2023

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Costa House Houghton Hall Business Park, Porz Avenue Houghton Regis Dunstable Bedfordshire LU5 5YG England a 3 Knaves Beech Business Centre Davies Way Loudwater High Wycombe Buckinghamshire HP10 9QR el 10 ene 2023

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    25 páginasAA

    Cese del nombramiento de Gillian Clare Mcdonald como director el 31 jul 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 dic 2021

    • Capital: GBP 51,275,365
    3 páginasSH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    25 páginasAA

    Cese del nombramiento de Bryan Keith Treadway como director el 30 jun 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Russell William Fairhurst como secretario el 14 may 2021

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Ms Sunita Savjani como secretario el 23 abr 2021

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de COSTA BEIJING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WERNER, Suzanne
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    Secretario
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    337540370001
    OTARID, Mounsef
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    Director
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    EnglandAmerican298905630002
    SCHAILLEE, Philippe Dirk M.
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    Director
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    NetherlandsBelgian308680130001
    FAIRHURST, Russell William
    37 Windermere Road
    Muswell Hill
    N10 2RD London
    Secretario
    37 Windermere Road
    Muswell Hill
    N10 2RD London
    British44556020003
    LOWRY, Darren Clive
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Secretario
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    197724200001
    SAVJANI, Sunita
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    Secretario
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    282623220001
    BARRATT, Simon Charles
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish14044440005
    COOK, Adrian Ernest
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    Director
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish291137910001
    CROOKALL, Jonathan Mark
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    Director
    Davies Way
    Loudwater
    HP10 9QR High Wycombe
    3 Knaves Beech Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish132778420001
    DERKACH, John
    Albert Terrace Mews
    NW1 7TA London
    20
    Director
    Albert Terrace Mews
    NW1 7TA London
    20
    United KingdomBritish113885080002
    FAIRHURST, Russell William
    37 Windermere Road
    Muswell Hill
    N10 2RD London
    Director
    37 Windermere Road
    Muswell Hill
    N10 2RD London
    EnglandBritish44556020003
    HIGHFIELD, Sarah Louise
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    Director
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish197724250001
    MARSHALL, Andrew John
    Yew Lodge
    Perryfield Road Southgate
    RH11 8AA Crawley
    West Sussex
    Director
    Yew Lodge
    Perryfield Road Southgate
    RH11 8AA Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish109616510001
    MCDONALD, Gillian Clare
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    Director
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish265351430001
    PAUL, Dominic James
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    Director
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish269740810001
    PRICE, Matthew John
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritish136221640001
    ROGERS, Christopher Charles Bevan
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park
    LU5 5XE Porz Avenue Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritish34678510004
    SELJEFLOT, Katherine Joanna
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    Director
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish218493760001
    TREADWAY, Bryan Keith
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    Director
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    United StatesAmerican281358630001
    WOODHOUSE, Loraine
    Flat 206 Pacific Wharf
    Rotherhithe Street
    SE16 5QF London
    Director
    Flat 206 Pacific Wharf
    Rotherhithe Street
    SE16 5QF London
    British101533500001
    WHITBREAD DIRECTORS 1 LIMITED
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Bedfordshire
    Director corporativo
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Bedfordshire
    98055530004
    WHITBREAD DIRECTORS 2 LIMITED
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Bedfordshire
    Director corporativo
    Whitbread Court
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    LU5 5XE Dunstable
    Bedfordshire
    98084330003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de COSTA BEIJING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    06 abr 2016
    Houghton Hall Business Park, Porz Avenue
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Costa House
    Bedfordshire
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01416662
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0