ALDERSGATE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaALDERSGATE LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 06205552
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ALDERSGATE LIMITED?

    • Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra ALDERSGATE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Sustainable Workspaces County Hall, 5th Floor
    Belvedere Road
    SE1 7PB London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ALDERSGATE LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 abr 2025
    Próximas cuentas vencen el31 ene 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ALDERSGATE LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta05 abr 2025
    Próxima declaración de confirmación vence19 abr 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta05 abr 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALDERSGATE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Ms Louise Ellen Harry como director el 10 oct 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andrew John Wilson como director el 10 oct 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert William Lambe como director el 10 oct 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2024

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Scott House, Suite 1, the Concourse Waterloo Station London SE1 7LY England a Sustainable Ventures County Hall, 5th Floor Belvedere Road London SE1 7PB

    1 páginasAD02

    Cambio de datos del secretario Miss Anne Patricia Smellie el 15 abr 2024

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de Sustainable Ventures, County Hall, 5th Floor Belvedere Road London SE1 7PB England a Sustainable Workspaces County Hall, 5th Floor Belvedere Road London SE1 7PB el 26 mar 2024

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 124 City Road London EC1V 2NX England a Sustainable Ventures, County Hall, 5th Floor Belvedere Road London SE1 7PB el 26 mar 2024

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Ms Michelle Anna Hubert como director el 12 oct 2023

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2023

    10 páginasAA

    Nombramiento de Ms Rachel Solomon Williams como director el 12 oct 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephanie Cynthia Maier como director el 12 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mary Thorogood como director el 12 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicolas Molho como director el 17 may 2023

    1 páginasTM01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 151 Wardour Street Wardour Street London W1F 8WE England a Scott House, Suite 1, the Concourse Waterloo Station London SE1 7LY

    1 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 abr 2022

    3 páginasAA

    Nombramiento de Ms Wafa Jafri como director el 22 sept 2022

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Ms Stephanie Cynthia Maier el 27 sept 2022

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Fiona Louise Ball como director el 22 sept 2022

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Daniel Matthew Johns el 28 jun 2022

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mary Thorogood el 28 jun 2022

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr. Jamie Agombar el 28 jun 2022

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Caroline May el 28 jun 2022

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de ALDERSGATE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMELLIE, Anne Patricia
    County Hall, 5th Floor
    Belvedere Road
    SE1 7PB London
    Sustainable Workspaces
    England
    Secretario
    County Hall, 5th Floor
    Belvedere Road
    SE1 7PB London
    Sustainable Workspaces
    England
    280901420001
    AGOMBAR, Jamie, Mr.
    Snape Road
    SK10 2NZ Macclesfield
    Ian King House
    England
    Director
    Snape Road
    SK10 2NZ Macclesfield
    Ian King House
    England
    EnglandBritishExecutive Director At Sos-Uk244442360001
    BARRETT, Julia Bernadette
    Bridge Road
    SG6 4ET Letchworth Garden City
    Suite 201, The Spirella Building
    England
    Director
    Bridge Road
    SG6 4ET Letchworth Garden City
    Suite 201, The Spirella Building
    England
    EnglandBritishDirector, Willmott Dixon Re-Thinking Limited138102920001
    HARRY, Louise Ellen
    PO BOX 4640
    SL1 0XZ Slough
    Siemens Plc
    England
    Director
    PO BOX 4640
    SL1 0XZ Slough
    Siemens Plc
    England
    United KingdomBritishDirector Of Sustainability & Ehs At Siemens Gb&I327330390001
    HUBERT, Michelle Anna
    County Hall, 5th Floor
    Belvedere Road
    SE1 7PB London
    Sustainable Workspaces
    England
    Director
    County Hall, 5th Floor
    Belvedere Road
    SE1 7PB London
    Sustainable Workspaces
    England
    EnglandBritishHead Of Public Affairs And Policy316182510001
    JAFRI, Wafa
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    England
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    England
    United KingdomBritish,PakistaniDirector, Energy Lead Advisory300514940001
    JOHNS, Daniel Matthew
    University Of Norwich
    University Drive
    NR4 7TJ Norwich
    Wre, The Enterprise Centre
    England
    Director
    University Of Norwich
    University Drive
    NR4 7TJ Norwich
    Wre, The Enterprise Centre
    England
    United KingdomBritishManaging Director At Water Resources East254782750001
    MAY, Caroline Elizabeth
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    Director
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    England
    United KingdomBritishHead Of Environment, Health And Safety142258770001
    SOLOMON WILLIAMS, Rachel
    Sustainable Ventures
    County Hall, 5th Floor
    SE1 7PB Belvedere Road
    Aldersgate Group
    London
    United Kingdom
    Director
    Sustainable Ventures
    County Hall, 5th Floor
    SE1 7PB Belvedere Road
    Aldersgate Group
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive314668930001
    SYMONS, David Stjohn
    c/o Wsp Parsons Brinckerhoff
    Devonshire Square
    EC2M 4YE London
    6
    England
    Director
    c/o Wsp Parsons Brinckerhoff
    Devonshire Square
    EC2M 4YE London
    6
    England
    EnglandBritishEnvironmental Consultant106110910001
    TURRELL, Anna Elizabeth
    Shire Park
    AL7 1TW Welwyn Garden City
    Tesco
    England
    Director
    Shire Park
    AL7 1TW Welwyn Garden City
    Tesco
    England
    EnglandBritishHead Of Environment186425130001
    WILSON, Andrew John
    Triton Square
    NW1 3AN London
    2
    England
    Director
    Triton Square
    NW1 3AN London
    2
    England
    United KingdomBritishDirector Of Communications And Marketing140716690002
    FLEMING-WILLIAMS, Victoria
    152-160 City Road
    EC1V 2NX London
    Kemp House
    United Kingdom
    Secretario
    152-160 City Road
    EC1V 2NX London
    Kemp House
    United Kingdom
    199814860001
    MUSAT, Anuta
    152-160 City Road
    EC1V 2NX London
    Kemp House
    United Kingdom
    Secretario
    152-160 City Road
    EC1V 2NX London
    Kemp House
    United Kingdom
    265433680001
    WILKES, Adrian Jerome
    71 Greencroft Gardens
    NW6 3LJ London
    Secretario
    71 Greencroft Gardens
    NW6 3LJ London
    BritishConsultant17040450003
    WILLIAMS, Sarah
    152-160 City Road
    EC1V 2NX London
    Kemp House
    United Kingdom
    Secretario
    152-160 City Road
    EC1V 2NX London
    Kemp House
    United Kingdom
    247788750001
    YOUNG, Peter
    New Zealand House
    80 Haymarket
    SW1Y 4TE London
    The Hub
    United Kingdom
    Secretario
    New Zealand House
    80 Haymarket
    SW1Y 4TE London
    The Hub
    United Kingdom
    153388560001
    YOUNG, Peter James, Dr
    26 Heol Powis
    Gungrog Hill
    SY21 7TP Welshpool
    Powys
    Secretario
    26 Heol Powis
    Gungrog Hill
    SY21 7TP Welshpool
    Powys
    BritishConsultant34310140001
    BALL, Fiona Louise
    Believe In Better Building
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Sky
    Middlesex
    England
    Director
    Believe In Better Building
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Sky
    Middlesex
    England
    EnglandBritishHead Of Responsible Business203645510001
    BOYD, Emma Howard
    Grosvenor Place
    SW1X 7JJ London
    1
    United Kingdom
    Director
    Grosvenor Place
    SW1X 7JJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector Of Aldersgate Group173034600001
    DICKIE, Ian Robert
    17 York Road
    SG5 1XA Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    17 York Road
    SG5 1XA Hitchin
    Hertfordshire
    United KingdomBritishEconomist123285310001
    DUDOK VAN HEEL, Oliver Lodewijk Frederick
    New Zealand House
    80 Haymarket
    SW1Y 4TE London
    Hub Westminster
    Uk
    Director
    New Zealand House
    80 Haymarket
    SW1Y 4TE London
    Hub Westminster
    Uk
    UkDutchNone179808410001
    EVANS, Penelope Mary
    Weyside Park
    GU7 1XR Godalming
    Panda House
    Surrey
    Director
    Weyside Park
    GU7 1XR Godalming
    Panda House
    Surrey
    EnglandBritishSenior Public Affairs Officer Wwf Uk173709360002
    GOUGH, Mark Simon
    152-160 City Road
    EC1V 2NX London
    Kemp House
    United Kingdom
    Director
    152-160 City Road
    EC1V 2NX London
    Kemp House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Sustainability191304000001
    HARMAN, John Andrew, Sir
    New North Road
    HD1 5NE Huddersfield
    82a
    West Yorkshire
    Director
    New North Road
    HD1 5NE Huddersfield
    82a
    West Yorkshire
    EnglandBritishChairman2199330001
    HERBERT, Luke
    New Zealand House
    80 Haymarket
    SW1Y 4TE London
    The Hub
    Director
    New Zealand House
    80 Haymarket
    SW1Y 4TE London
    The Hub
    EnglandUkHead Of Uk Government Affairs191402810001
    HILL, Rowland
    Rosemullion Ave
    MK4 3AY Tattenhoe, Milton Keynes
    102
    United Kingdom
    Director
    Rosemullion Ave
    MK4 3AY Tattenhoe, Milton Keynes
    102
    United Kingdom
    United KingdomBritishSustainability And Reporting Manager241839530001
    JENKINS, Timothy
    14 Brincliffe Crescent
    S11 9AW Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    14 Brincliffe Crescent
    S11 9AW Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishResearcher123285270001
    LAMBE, Robert William
    Bridge Road
    SG6 4ET Letchworth
    Suite 211 The Spirella Building
    Hertfordshire
    England
    Director
    Bridge Road
    SG6 4ET Letchworth
    Suite 211 The Spirella Building
    Hertfordshire
    England
    EnglandIrishConstruction Company Director127211270001
    MAIER, Stephanie Cynthia
    Finsbury Circus
    EC2M 7GB London
    8
    England
    Director
    Finsbury Circus
    EC2M 7GB London
    8
    England
    EnglandBritishHead Of Responsible Investment Strategy & Research182557960001
    MITCHELL, Edward James Alfred Kirkland
    29-31 Wallingford Street
    OX12 8AU Wantage
    Alton House
    Oxfordshire
    Director
    29-31 Wallingford Street
    OX12 8AU Wantage
    Alton House
    Oxfordshire
    EnglandBritishEnvirionmental Regulator104350840002
    MOLHO, Nicolas Jacques
    Waterloo Station
    SE1 7LY London
    Suite 1, The Concourse
    England
    Director
    Waterloo Station
    SE1 7LY London
    Suite 1, The Concourse
    England
    EnglandBritish,FrenchExecutive Director195428740001
    RAINGOLD, Andrew Henry
    Torrens Street
    EC1V 1NQ London
    The Hub 5
    Uk
    Director
    Torrens Street
    EC1V 1NQ London
    The Hub 5
    Uk
    UkBritishExecutive Director134365060001
    THOROGOOD, Mary
    Queens Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    20
    Scotland
    Director
    Queens Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    20
    Scotland
    EnglandBritishGovernment Relations, External Affairs And Communi241839790003
    TUPPEN, Christopher George
    New Zealand House
    80 Haymarket
    SW1Y 4TE London
    The Hub
    United Kingdom
    Director
    New Zealand House
    80 Haymarket
    SW1Y 4TE London
    The Hub
    United Kingdom
    EnglandEnglishConsultant155351520001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para ALDERSGATE LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    05 abr 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0