OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 06265141
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bupa Dental Care Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DUKE STREET CAPITAL OASIS HOLDINGS LIMITED31 may 200731 may 2007

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 08 may 2020 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    29 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Estado de capital el 12 dic 2019

    • Capital: GBP 2.00
    6 páginasSH02

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 12 dic 2019

    • Capital: GBP 151,285.32
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share prem/cap redempt res cancelled 12/12/2019
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 12 dic 2019

    • Capital: GBP 117,782,222.89
    4 páginasSH01

    Cese del nombramiento de Ian David Wood como director el 19 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robin James Bryant como director el 19 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steven John Preddy como director el 19 nov 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2018

    19 páginasAA

    legacy

    48 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 08 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Gabriela Pueyo Roberts como director el 01 feb 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Catherine Elizabeth Barton como director el 05 dic 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Dr Steven John Preddy como director el 14 sept 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Edward Joseph Coyle como director el 14 sept 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 08 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2017

    19 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3155937
    162768400001
    PUEYO ROBERTS, Gabriela
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    SpainSpanish254904830001
    WRIGHT, Jake Hockley
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    United KingdomBritish184341770001
    BRADSHAW, Paula Kirsten
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Secretario
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    179393760001
    BRADSHAW, Paula
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Secretario
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    156233190001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Secretario
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    169813810001
    HOLDCROFT, Andrew Darren
    9 Samford Court
    Tattingstone
    IP9 2NQ Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    9 Samford Court
    Tattingstone
    IP9 2NQ Ipswich
    Suffolk
    British83074650002
    MATHARU, Manmohan Singh
    46 Warren Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3LW Leicester
    Leicestershire
    Secretario
    46 Warren Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3LW Leicester
    Leicestershire
    British49500020001
    OWEN, Jennifer Margaret
    Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    138
    Hertfordshire
    Secretario
    Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    138
    Hertfordshire
    English188565910001
    TAYLOR, Peter Lance
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    Secretario
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    British92125620001
    TINDALL, Zoe
    Portbury Lane
    Portbury
    BS20 7SN Bristol
    Higher Farm Barn
    North Somerset
    Secretario
    Portbury Lane
    Portbury
    BS20 7SN Bristol
    Higher Farm Barn
    North Somerset
    British138730340001
    QUAYSECO LTD
    Glass Wharf
    BS2 0ZX Bristol
    One
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Glass Wharf
    BS2 0ZX Bristol
    One
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02287256
    163574790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Paul James
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish161490290001
    ASH, Justinian Joseph
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish188659180001
    BARTON, Catherine Elizabeth
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    EnglandBritish243693740001
    BELKIN, Jeffrey Philip
    10a Sherriff Road
    NW6 2AU West Hampstead
    London
    Director
    10a Sherriff Road
    NW6 2AU West Hampstead
    London
    United KingdomBritish79906460001
    BRYANT, Robin James, Dr
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    United KingdomBritish169089950001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish113187140001
    COLVIN, William
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    United KingdomBritish51697890002
    COX, Grahame Philip
    Crooked Cottage
    Chapel Allerton
    BS26 2PH Axbridge
    Somerset
    Director
    Crooked Cottage
    Chapel Allerton
    BS26 2PH Axbridge
    Somerset
    EnglandBritish54310790001
    COYLE, Edward Joseph, Dr
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    United KingdomBritish200405130002
    GONZALEZ, Jordi
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    United KingdomBritish183345110001
    HARPER, John David
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    United KingdomBritish193479730001
    HARPER, John
    30 Holmside Road
    SW12 8RJ London
    Director
    30 Holmside Road
    SW12 8RJ London
    British109430090001
    HOFF, Lilimarlen
    Flat 7
    23 Queensgate Terrace
    SW7 5PR London
    Director
    Flat 7
    23 Queensgate Terrace
    SW7 5PR London
    British121879120001
    HOLDCROFT, Andrew Darren
    9 Samford Court
    Tattingstone
    IP9 2NQ Ipswich
    Suffolk
    Director
    9 Samford Court
    Tattingstone
    IP9 2NQ Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish83074650002
    JOHNSON, Allan
    2 Church Cottages
    OX20 1DZ Wootton
    Oxfordshire
    Director
    2 Church Cottages
    OX20 1DZ Wootton
    Oxfordshire
    EnglandBritish159246050001
    LAMBERT, Stephen David
    High House 36 South Avenue
    NR7 0EZ Norwich
    Norfolk
    Director
    High House 36 South Avenue
    NR7 0EZ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish99698180001
    LEATHERBARROW, David Jon
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    EnglandBritish135618280010
    LEATHERBARROW, David Jon
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish135618280002
    MATHARU, Manmohan Singh
    46 Warren Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3LW Leicester
    Leicestershire
    Director
    46 Warren Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3LW Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish49500020001
    MULLORD, Kathleen
    11 St Stephens Walk
    SW7 4RP London
    Director
    11 St Stephens Walk
    SW7 4RP London
    United KingdomSouth African118838430001
    PERRY, Julian Francis
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish84437900002
    PHILIPPS, Corinne
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Director
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    United KingdomFrench,British109733120002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro08405885
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 25 jul 2014
    Entregado el 31 jul 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Societe Generale, London Branch as Security Agent
    Transacciones
    • 31 jul 2014Registro de una carga (MR01)
    • 10 feb 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A security agreement
    Creado el 13 jun 2007
    Entregado el 22 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 22 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0