OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 06265141 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | Bupa Dental Care Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DUKE STREET CAPITAL OASIS HOLDINGS LIMITED | 31 may 2007 | 31 may 2007 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2020 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 29 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 12 dic 2019
| 6 páginas | SH02 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 12 dic 2019
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 12 dic 2019
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Ian David Wood como director el 19 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Robin James Bryant como director el 19 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Steven John Preddy como director el 19 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2018 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 48 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Gabriela Pueyo Roberts como director el 01 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Catherine Elizabeth Barton como director el 05 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Dr Steven John Preddy como director el 14 sept 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Edward Joseph Coyle como director el 14 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2017 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom |
| 162768400001 | ||||||||||
| PUEYO ROBERTS, Gabriela | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | Spain | Spanish | 254904830001 | |||||||||
| WRIGHT, Jake Hockley | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 184341770001 | |||||||||
| BRADSHAW, Paula Kirsten | Secretario | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | 179393760001 | |||||||||||
| BRADSHAW, Paula | Secretario | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | 156233190001 | |||||||||||
| CAMERON, Charles Donald Ewen | Secretario | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | 169813810001 | |||||||||||
| HOLDCROFT, Andrew Darren | Secretario | 9 Samford Court Tattingstone IP9 2NQ Ipswich Suffolk | British | 83074650002 | ||||||||||
| MATHARU, Manmohan Singh | Secretario | 46 Warren Lane Leicester Forest East LE3 3LW Leicester Leicestershire | British | 49500020001 | ||||||||||
| OWEN, Jennifer Margaret | Secretario | Clarence Road AL1 4NW St Albans 138 Hertfordshire | English | 188565910001 | ||||||||||
| TAYLOR, Peter Lance | Secretario | Almack House 28 King Street SW1Y 6XA London | British | 92125620001 | ||||||||||
| TINDALL, Zoe | Secretario | Portbury Lane Portbury BS20 7SN Bristol Higher Farm Barn North Somerset | British | 138730340001 | ||||||||||
| QUAYSECO LTD | Secretario corporativo | Glass Wharf BS2 0ZX Bristol One United Kingdom |
| 163574790001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ADAMS, Paul James | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 161490290001 | |||||||||
| ASH, Justinian Joseph | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 188659180001 | |||||||||
| BARTON, Catherine Elizabeth | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 243693740001 | |||||||||
| BELKIN, Jeffrey Philip | Director | 10a Sherriff Road NW6 2AU West Hampstead London | United Kingdom | British | 79906460001 | |||||||||
| BRYANT, Robin James, Dr | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 169089950001 | |||||||||
| CAMERON, Charles Donald Ewen | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 113187140001 | |||||||||
| COLVIN, William | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | United Kingdom | British | 51697890002 | |||||||||
| COX, Grahame Philip | Director | Crooked Cottage Chapel Allerton BS26 2PH Axbridge Somerset | England | British | 54310790001 | |||||||||
| COYLE, Edward Joseph, Dr | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 200405130002 | |||||||||
| GONZALEZ, Jordi | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | United Kingdom | British | 183345110001 | |||||||||
| HARPER, John David | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | United Kingdom | British | 193479730001 | |||||||||
| HARPER, John | Director | 30 Holmside Road SW12 8RJ London | British | 109430090001 | ||||||||||
| HOFF, Lilimarlen | Director | Flat 7 23 Queensgate Terrace SW7 5PR London | British | 121879120001 | ||||||||||
| HOLDCROFT, Andrew Darren | Director | 9 Samford Court Tattingstone IP9 2NQ Ipswich Suffolk | England | British | 83074650002 | |||||||||
| JOHNSON, Allan | Director | 2 Church Cottages OX20 1DZ Wootton Oxfordshire | England | British | 159246050001 | |||||||||
| LAMBERT, Stephen David | Director | High House 36 South Avenue NR7 0EZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 99698180001 | |||||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 135618280010 | |||||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 135618280002 | |||||||||
| MATHARU, Manmohan Singh | Director | 46 Warren Lane Leicester Forest East LE3 3LW Leicester Leicestershire | England | British | 49500020001 | |||||||||
| MULLORD, Kathleen | Director | 11 St Stephens Walk SW7 4RP London | United Kingdom | South African | 118838430001 | |||||||||
| PERRY, Julian Francis | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 84437900002 | |||||||||
| PHILIPPS, Corinne | Director | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | United Kingdom | French,British | 109733120002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Healthcare Bidco Limited | 06 abr 2016 | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 25 jul 2014 Entregado el 31 jul 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A security agreement | Creado el 13 jun 2007 Entregado el 22 jun 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0