AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 06408392 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Park Row LS1 5AB Leeds |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BAA (NDH1) LIMITED | 03 abr 2008 | 03 abr 2008 |
| BAA (NEWCO1) LIMITED | 20 dic 2007 | 20 dic 2007 |
| BAA (AH) LIMITED | 24 oct 2007 | 24 oct 2007 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 24 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 24 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancelación total de la carga 064083920014 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 064083920012 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 064083920013 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Registro de la carga 064083920016, creada el 08 dic 2025 | 21 páginas | MR01 | ||||||
Registro de la carga 064083920015, creada el 08 dic 2025 | 63 páginas | MR01 | ||||||
Cambio de datos del director Mr Karan Singh Jandu el 23 may 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Nombramiento de Amanda Jane Aldridge como director el 23 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de David Edwards como director el 23 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 22 páginas | AA | ||||||
Nombramiento de Ms Gabrielle Louise Dale como director el 12 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Nombramiento de Mr David Edwards como director el 12 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Nombramiento de Margaret Christine Browne Obe como director el 12 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Segunda presentación para el nombramiento de Mr Karan Singh Jandu como director | 3 páginas | RP04AP01 | ||||||
Cambio de datos del director Mr Charles Graham Hammond el 28 ene 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||
Cessation de Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 ene 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||
Cessation de Faero Uk Holding Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 ene 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||
Nombramiento de Mr Gerhard Gunter Schroeder como director el 28 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Nombramiento de Mr Charles Graham Hammond como director el 28 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Nombramiento de Mr Dennis Krein como director el 28 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Nombramiento de Mrs Anke Heinze como director el 28 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Nombramiento de Mr Karan Singh Jandu como director el 28 ene 2025 | 3 páginas | AP01 | ||||||
| ||||||||
Cese del nombramiento de Andrew James Cliffe como director el 28 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cese del nombramiento de Shawn Michael Kinder como director el 28 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cese del nombramiento de Madhulika Saraf como director el 28 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||
¿Quiénes son los directivos de AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| ALDRIDGE, Amanda Jane | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 | United Kingdom | British | 340651510001 | |||||||||
| BROWNE OBE, Margaret Christine | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 | United Kingdom | British,Irish | 335705170001 | |||||||||
| DALE, Gabrielle Louise | Director | Berkeley Square W1J 5AL London 40 United Kingdom | United Kingdom | Australian,British | 191316940001 | |||||||||
| HAMMOND, Charles Graham | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | Scotland | British | 498460009 | |||||||||
| HEINZE, Anke | Director | 40468 Dusseldorf Klaus-Bungert-Strasse 5 Germany | Germany | German | 331825780001 | |||||||||
| JANDU, Karan Singh | Director | Erskine Court St Andrews Drive PA3 2SW Paisley C/0 Ags Airports Limited Renfrewshire Scotland | United Kingdom | British | 331891720002 | |||||||||
| KREIN, Dennis | Director | 40468 Dusseldorf Klaus-Bungert-Strasse 5 Germany | Germany | German | 331825280001 | |||||||||
| SCHROEDER, Gerhard Gunter | Director | 40468 Dusseldorf Klaus-Bungert-Strasse 5 Germany | Germany | German | 331874820001 | |||||||||
| OOI, Shu Mei | Secretario | Nelson Road Hounslow TW6 2GW Middlesex The Compass Centre | British | 135131550001 | ||||||||||
| WELCH, Susan | Secretario | 130 Wilton Road SW1V 1LQ London | British | 113328470004 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario corporativo | 1 Mitchell Lane BS1 6BU Bristol | 111451340001 | |||||||||||
| ABEL, Richard | Director | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place United Kingdom | United Kingdom | British | 155181590001 | |||||||||
| BILBAO, Ignacio Aitor Garcia | Director | Quintanavides 21 Madrid Parque Via Norte, Calle 28050 Spain | Spain | Spanish | 193797520001 | |||||||||
| BRUEN, John Kevin | Director | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place United Kingdom | United Kingdom | Irish | 190644600001 | |||||||||
| CARLISLE, Andrew Richard | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | England | British | 140916960002 | |||||||||
| CASERO BORGES, Maria Cristina | Director | Kingsfordweg 1043 GR Amsterdam 151 Netherlands | Netherlands | Spanish | 307887850001 | |||||||||
| CASTEJON HERNANDEZ, Ignacio | Director | Calle Quintanavides 21 28050 Madrid Parque Via Norte Spain | Spain | Spanish | 271078600001 | |||||||||
| CLIFFE, Andrew James | Director | Erskine Court St Andrews Drive PA3 2TJ Paisley Administration Building Renfrewshire United Kingdom | England | British | 304634610001 | |||||||||
| EDWARDS, David | Director | Berkeley Square W1J 5AL London 40 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 335705180001 | |||||||||
| GEERE, Simon Boyd | Director | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place United Kingdom | United Kingdom | British | 89422150003 | |||||||||
| KENNY, David John | Director | Calle Del Principe De Vergara 28002 Madrid 135 Spain | Spain | Australian | 300626490001 | |||||||||
| KINDER, Shawn Michael | Director | 151 1043 GR Amsterdam Kingsfordweg Netherlands | Netherlands | American | 314210820001 | |||||||||
| LEO, Jose | Director | Nelson Road TW6 2GW Hounslow The Compass Centre Middlesex | Spanish | 116370720007 | ||||||||||
| LOPEZ SORIA, Fidel | Director | Nelson Road Hounslow TW6 2GW Middlesex The Compass Centre United Kingdom | Spain | Spanish | 155347920001 | |||||||||
| MAROUDAS, Frederick Ian | Director | Nelson Road Hounslow TW6 2GW Middlesex The Compass Centre | England | British | 140143930001 | |||||||||
| MCMILLAN, Amanda Eliza | Director | Glasgow Airport PA3 2SW Paisley St Andrews Drive United Kingdom | Scotland | British | 135306540001 | |||||||||
| NELSON, Stephen Keith James | Director | 130 Wilton Road SW1V 1LQ London | British | 112402740001 | ||||||||||
| O'SULLIVAN, James Christopher | Director | Nelson Road Hounslow TW6 2GW Middlesex The Compass Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 287765600001 | |||||||||
| ONADERRA, Miguel Rodera | Director | Calle Del Principe De Vergara 28002 Madrid 135 Spain | Spain | Spanish | 304513380001 | |||||||||
| PARSONS, Gordon Ian Winston | Director | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place United Kingdom | United Kingdom | British | 307403190001 | |||||||||
| PROVAN, Derek | Director | Bedford Row WC1R 4JS London 20-22 United Kingdom | Scotland | British | 308336370001 | |||||||||
| SANCHEZ SALMERON, Luis Angel | Director | 130 Wilton Road SW1V 1LQ London | Spanish | 115544420001 | ||||||||||
| SARAF, Madhulika | Director | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place United Kingdom | United Kingdom | British | 307399760001 | |||||||||
| SORIA, Fidel Lopez | Director | Calle Quintanavides 21 Madrid Parque Via Norte 28050 Spain | Spain | Spanish | 191350430001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AIRPORT HOLDINGS NDH1 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Infrastructure And Real Assets (Europe) Limited | 06 abr 2016 | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Faero Uk Holding Limited | 06 abr 2016 | Building 5, Chiswick Business Park 566 Chiswick Park W4 5YS London 3rd Floor United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ags Airports Limited | 06 abr 2016 | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0