OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 06472486 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED?
Dirección de la sede social | West 3 Atlantic Avenue Corringham SS17 9ER Stanford-Le-Hope Essex England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 oct 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 jul 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 02 abr 2026 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 16 abr 2026 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 02 abr 2025 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr Ivo Vesselinov como secretario el 22 abr 2025 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ross Conor O'brien como secretario el 27 mar 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de West 3 Atlantic Avenue Stanford-Le-Hope Essex SS17 9FE a West 3 Atlantic Avenue Corringham Stanford-Le-Hope Essex SS17 9ER el 24 feb 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Quadrant 1 Homefield Road Haverhill Suffolk CB9 8QP England a West 3 Atlantic Avenue Stanford-Le-Hope Essex SS17 9FE el 04 feb 2025 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2023 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael John Speakman como director el 07 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ivaylo Alexandrov Vesselinov como director el 07 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian O'donovan como director el 07 feb 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2022 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Upton como director el 15 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 8 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 064724860009, creada el 22 dic 2022 | 49 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 064724860008 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Upton como director el 03 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ross Conor O'brien como secretario el 03 ago 2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Espen Halvorsen como director el 03 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian O'donovan como secretario el 03 ago 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2021 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2020 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2019 | 28 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESSELINOV, Ivo | Secretario | Corringham SS17 9ER Stanford-Le-Hope West 3 Atlantic Avenue Essex England | 334944340001 | |||||||
SPEAKMAN, Michael John | Director | Corringham SS17 9ER Stanford-Le-Hope West 3 Atlantic Avenue Essex England | England | British | Managing Director Uki Oasis Group | 319380030001 | ||||
VESSELINOV, Ivaylo Alexandrov | Director | Corringham SS17 9ER Stanford-Le-Hope West 3 Atlantic Avenue Essex England | England | British | Finance Director | 239696980002 | ||||
CARROLL, Ronnie | Secretario | Portman Road RG30 1EA Reading 60 Berkshire | British | 156737880001 | ||||||
CHENDO, John Michael Gray | Secretario | Portman Road RG30 1EA Reading 60 Berkshire | American | 139299540001 | ||||||
CONNOLLY, Brian | Secretario | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | British | 189490100001 | ||||||
MANIFOLD, David | Secretario | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | 250959600001 | |||||||
MCELROY, Gary | Secretario | Stradbrook Lawn Blackrock Dublin 21 County Dublin Ireland | Irish | Director | 238458310001 | |||||
O'BRIEN, Ross Conor | Secretario | Corringham SS17 9ER Stanford-Le-Hope West 3 Atlantic Avenue Essex England | 298788320001 | |||||||
O'DONOVAN, Ian | Secretario | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | 261261740001 | |||||||
PATTON, Richard Frederick | Secretario | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | 237513990001 | |||||||
BBM SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Alexander House Bethesda Street Hanley ST1 3DX Stoke On Trent Staffordshire | 124981190001 | |||||||
BARNEDT III, Dennis E | Director | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | Usa | American | Ceo | 148578630001 | ||||
CHENDO, John Michael Gray | Director | Portman Road RG30 1EA Reading 60 Berkshire | Usa | American | Investor | 139299540001 | ||||
CONNOLLY, Brian | Director | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | Ireland | Irish | Director | 231652570001 | ||||
HALVORSEN, Espen | Director | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | Norway | Norwegian | Interim Ceo | 263486850001 | ||||
MANIFOLD, David | Director | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | Ireland | Irish | Chief Financial Officer | 250955610001 | ||||
MCCORMICK, Peter William | Director | The Crescent Hollywood 3 County Down | Northern Ireland | Irish | Director | 143608490001 | ||||
MCELROY, Gary | Director | Preston Road RG2 0BE Reading 1-5 Berkshire | Ireland | Irish | Director | 238458310001 | ||||
MINA, Alessandro | Director | Portman Road RG30 1EA Reading 60 Berkshire | Usa | Swedish | Investor | 154280720001 | ||||
O'DONOVAN, Ian | Director | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | Ireland | Irish | Cfo | 261257010001 | ||||
PATTON, Richard Frederick | Director | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | Ireland | Irish | Accountant | 237512460001 | ||||
PORTER, Stewart Thomas Graves | Director | Portman Road RG30 1EA Reading 60 Berkshire | Northern Ireland | Scottish | Director | 173813420001 | ||||
REID, Glen Thomas | Director | 62 Applewood Heights IRISH Greystones Wicklow Ireland | Irish | Director | 81460830001 | |||||
ROGERS, Desmond | Director | Portman Road RG30 1EA Reading 60 Berkshire | Republic Of Ireland | Irish | Director | 144329600001 | ||||
SOUTHERN, Michael Robert John | Director | Shepherds Lane Caversham RG4 7JL Reading Tudor Lodge 20 Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 129379780001 | ||||
STEBER, Martin | Director | Portman Road RG30 1EA Reading 60 Berkshire | Switzerland | German/Swiss/Canadian | Investor | 139299310001 | ||||
THORNDIKE JR, William N | Director | Portman Road RG30 1EA Reading 60 Berkshire | Usa | American | Investor | 139299560001 | ||||
UPTON, Andrew | Director | Homefield Road CB9 8QP Haverhill Quadrant 1 Suffolk England | England | English | Ceo | 298787490001 | ||||
BBM DIRECTORS LIMITED | Director corporativo | Alexander House Bethesda Street Hanley ST1 3DE Stoke On Trent Staffordshire | 111798840001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montagu Private Equity Llp | 15 ago 2017 | More London Riverside SE1 2AP London 2 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mpe (General Partner V) Ltd | 15 ago 2017 | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Offsite Archive Storage And Integrated Services (Ireland) Limited | 01 jun 2016 | Kinsealy Business Park Kinsealy Unit 15c Dublin Ireland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para OFFSITE ARCHIVE STORAGE AND INTEGRATED SERVICES (UK) LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
02 abr 2017 | 15 ago 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0