KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 06511474 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TURBO ALPHA II LIMITED | 21 feb 2008 | 21 feb 2008 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 156 Great Charles Street Queensway Birmingham B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 15 nov 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 jun 2022 | 8 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Joseph Byrne como secretario el 31 dic 2021 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Park Row Leeds LS1 5AB England a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham B3 3HN el 16 jul 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 9 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 065114740004 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 065114740003 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 065114740005 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2019 au 30 jun 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John James Ensall como director el 21 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John James Ensall como director el 06 may 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Vahid Farzad como director el 29 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Salah Abdelhadi Abdullah Al Qahtani como director el 29 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Markku Juhani Lonnqvist como director el 29 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dean Edward John Merritt como director el 29 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Benjamin James Babcock como director el 29 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David P. Trucano como director el 29 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Abdulla Nasser Ahmed Huwaileel Al Mansoori como director el 29 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Benjamin James Babcock como director el 09 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELKHOURY, Joseph | Director | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | United Kingdom | American | 281465670001 | |||||
| ELLIS, Robert Keith | Director | Holmesdale Road Holmesdale Road TW11 9LJ Teddington 27 Middlesex England | England | British | 154853690001 | |||||
| GILCHRIST, Neil Porteous | Director | Minto Drive Altens Industrial Estate AB12 3LW Aberdeen C/O Kca Deutag Drilling Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 175428360003 | |||||
| ANDREW, Louise | Secretario | Colthill Road AB13 0EF Milltimber 16 Aberdeen | British | 137991060004 | ||||||
| BYRNE, Anthony Joseph | Secretario | Minto Drive Altens Industrial Estate AB12 3LW Aberdeen Kca Deutag Drilling Group Limited Scotland | 200647140001 | |||||||
| BYRNE, Anthony Joseph | Secretario | Minto Drive Altens Industrial Estate AB12 3LW Aberdeen Kca Deutag Drilling Group Limited Scotland | 192861250001 | |||||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Secretario | Minto Drive Altens Industrial Estate AB12 3LW Aberdeen Kca Deutag Drilling Limited Scotland | 196066940001 | |||||||
| HARTLEY, Neil John | Secretario | Sunnyside Of Collonach Strachan AB31 6NL Banchory Kincardineshire | British | 95128280002 | ||||||
| THOMSON, Lynne | Secretario | c/o Lynn Mutch Minto Drive Altens Industrial Estate AB12 3LW Aberdeen Kca Deutag Drilling Limited Aberdeenshire Scotland | 187016770001 | |||||||
| TRUSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||
| TRUSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||
| AL MANSOORI, Abdulla Nasser Ahmed Huwaileel | Director | c/o Al Nasser Holdings Llc Level 18, Capital Centre Behind Exhibition Centre 46611 Abu Dhabi Liwa Tower United Arab Emirates | United Arab Emirates | Emirati | 245921720001 | |||||
| AL QAHTANI, Salah Abdelhadi Abdullah, Sheikh | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England | Saudi Arabia | Saudi Arabian | 245920680002 | |||||
| BABCOCK, Benjamin James | Director | Cornwall Gardens Flat 1 SW7 4AZ London 82 England | England | British | 266368450001 | |||||
| BIALAS, Edward Todd | Director | Highview Avenue Old Greenwich 3 Ct 06870 United States | Usa | United States | 129371260002 | |||||
| DEFELICE, Alexander, Director | Director | 55 East 52nd Street 6th Floor New York Blackrock, Inc. New York 10055 United States | Usa Connecticut | United States | 159099590001 | |||||
| EDWARDS, Joseph Robert | Director | 3 Hill Road Greenwich Ct 068630 Usa | Usa | United States | 126282640001 | |||||
| ELLIS, Robert Keith | Director | Holmesdale Road TW11 9LJ Teddington 27 Middlesex | England | British | 154853690001 | |||||
| ENSALL, John James | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England | United Kingdom | British | 55694570002 | |||||
| FARZAD, Vahid | Director | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England | England | British | 209238340001 | |||||
| HALSTED, John Combothekras | Director | Park Lane W1K 1RA London 25 United Kingdom | United Kingdom | American | 141559270001 | |||||
| HARTLEY, Neil John | Director | Sunnyside Of Collonach Strachan AB31 6NL Banchory Kincardineshire | Scotland | British | 95128280002 | |||||
| HICKEY, Patrick Hunt, Senior Vice President | Director | Clay Street Houston 333 Texas Tx77002 United States | Usa Texas | United States | 159099720001 | |||||
| HUGHES, Christopher John | Director | 6 Snow Hill EC1A 2AY London Talbot Hughes Mckillop Llp England | United Kingdom | British | 12714590003 | |||||
| KNASTER, Alexander | Director | C/O Pamplona Capital Management 17th Floor, 375 Park Avenue New York 375 Usa | Usa | British | 100708060004 | |||||
| LODGE, Ted S | Director | Park Avenue 20th Floor New York Goldentree Asset Management, Lp, 300 New York 10022 Usa | Usa Pennsylvania | United States | 159218510001 | |||||
| LONNQVIST, Markku Juhani | Director | Park Lane W1K 1RA London 25 England | England | Finnish | 191990230001 | |||||
| LONNQVIST, Markku Juhani | Director | Park Lane W1K 1RA London 25 Uk | England | Finnish | 156734350001 | |||||
| MCKAY, Norrie Andrew | Director | Villa 9 Cluster 35 Jumeirah Islands Dubai United Arab Emirates | Dubai, United Arab Emirates | British | 183189560001 | |||||
| MERRITT, Dean Edward John | Director | Padhams Green Road CM4 9NY Ingatestone Westlands Cottage Essex England | United Kingdom | British | 141247230001 | |||||
| MILNE, Peter John | Director | Craigwood Blairs AB12 5YT Aberdeen | Scotland | British | 33613400008 | |||||
| MONIR, Nicole Frances | Director | 92 Crosslands Caddington LU1 4ER Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | 102866950001 | |||||
| PRINGLE, Keith James | Director | The Nelmes Munsley HR8 2SH Ledbury Herefordshire | Uk | Uk | 61942150003 | |||||
| SCHWARTZ, Alan | Director | 15 Sunflower Drive Saddle River Nj 07458 Usa | Usa | United States | 126282630001 | |||||
| SUMMERS, Timothy David | Director | c/o Kca Deutag Dreikonigstrasse 31a Zurich 8002 Switzerland | Switzerland | British | 157012920001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kcad Holdings Ii Limited | 06 abr 2016 | Colmore Circus Queensway B4 6BH Birmingham 3 Colmore Circus England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 27 abr 2018 Entregado el 03 may 2018 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Not applicable. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 05 abr 2017 Entregado el 13 abr 2017 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 16 may 2014 Entregado el 23 may 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 08 may 2013 Entregado el 13 may 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating security document | Creado el 15 mar 2008 Entregado el 26 mar 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any chargor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All its present and future title and interest in and to the assigned contracts, including all moneys and any claims, see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene KCA DEUTAG ALPHA II LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0