PK FOOD CONCEPTS LTD.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPK FOOD CONCEPTS LTD.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 07043579
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PK FOOD CONCEPTS LTD.?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra PK FOOD CONCEPTS LTD.?

    Dirección de la sede social
    C/O BDO LLP
    5 Temple Square Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PK FOOD CONCEPTS LTD.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GELLAW 321 LIMITED15 oct 200915 oct 2009

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PK FOOD CONCEPTS LTD.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PK FOOD CONCEPTS LTD.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    18 páginasLIQ14

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Bdo Llp 6th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL England a 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH el 11 oct 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 ago 2020

    15 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 30 ago 2019

    LRESEX

    Declaración de asuntos

    10 páginasLIQ02

    Domicilio social registrado cambiado de 82 Upper Hanover Street Sheffield S3 7RQ England a C/O Bdo Llp 6th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 08 ago 2019

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Plantation House Milber Trading Estate Newton Abbot Devon TQ12 4SG a 82 Upper Hanover Street Sheffield S3 7RQ el 12 jul 2019

    1 páginasAD01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2018 au 29 jun 2018

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de David John Turner como director el 28 sept 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr James Oliver Tugwell como director el 28 sept 2018

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2018 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    The "agreement"/the "sale" 10/08/2018
    RES13
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 7,200
    3 páginasSH03

    Cese del nombramiento de Paul Kingsley-Bates como director el 10 ago 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Gavin Eliot Cox como director el 10 ago 2018

    2 páginasAP01

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 05 jun 2018

    • Capital: GBP 84,900.00
    6 páginasSH06

    Compra de acciones propias.

    3 páginasSH03

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2017

    31 páginasAA

    Cese del nombramiento de Guy Truman como director el 30 abr 2018

    1 páginasTM01

    Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif

    5 páginasPSC05

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 10 sept 2017

    • Capital: GBP 84,900.00
    6 páginasSH06

    Compra de acciones propias.

    3 páginasSH03

    Cese del nombramiento de Lawrence George Dean como director el 30 sept 2017

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PK FOOD CONCEPTS LTD.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COX, Gavin Eliot
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    Director
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    EnglandBritishDirector196269790002
    TUGWELL, James Oliver
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    Director
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    EnglandBritishInvestment Manager250886890001
    CRESCENT HILL LIMITED
    Dumfries Place
    CF10 3ZF Cardiff
    Dumfries House
    Secretario corporativo
    Dumfries Place
    CF10 3ZF Cardiff
    Dumfries House
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2118529
    37545800001
    BABINGTON, Richard Anthony
    c/o Nbgi Private Equity
    Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House, 128
    United Kingdom
    Director
    c/o Nbgi Private Equity
    Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    Old Change House, 128
    United Kingdom
    EnglandBritishPrivate Equity Manager119187350001
    BORKOWSKI, Andrew Thomas
    Enterprise Way
    Ng2 Business Park
    NG2 1EN Nottingham
    The Arc
    Nottinghamshire
    Director
    Enterprise Way
    Ng2 Business Park
    NG2 1EN Nottingham
    The Arc
    Nottinghamshire
    EnglandBritishSolicitor110726660001
    COLE, Michael John
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    Director
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    UkBritishCompany Director148082790001
    DEAN, Lawrence George
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    Director
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    EnglandBritishDirector257514460001
    FARQUHAR, Howard Robert
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    Director
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    EnglandEnglishCompany Director91531020001
    KINGSLEY-BATES, Paul
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    Director
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    United KingdomBritishDirector193929530001
    MCANENA, Fiona
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    Director
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    EnglandBritishDirector109905840001
    RAOUX, Antoine Fabien
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    Director
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    EnglandFrenchDirector170568300001
    RICK, Ian Mark, Mr.
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    Director
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    EnglandEnglishFinance Director121583910001
    TRUMAN, Guy
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    Director
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    EnglandBritishSales Director152275270001
    TURNER, David John
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    Director
    Milber Trading Estate
    TQ12 4SG Newton Abbot
    Plantation House
    Devon
    EnglandBritishInvestment Director237815760001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PK FOOD CONCEPTS LTD.?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Stage Capital Management Limited
    Dover Street
    W1S 4ND London
    31
    England
    01 oct 2016
    Dover Street
    W1S 4ND London
    31
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegistrar Of Companies
    Número de registro10024328
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Nbgi Private Equity Fund Ii Llp
    Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    128
    England
    06 abr 2016
    Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    128
    England
    Forma jurídicaLlp
    Autoridad legalLlp Act 2000
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene PK FOOD CONCEPTS LTD. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 14 mar 2017
    Entregado el 20 mar 2017
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Nbgi Private Equity Fund Ii LP (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 20 mar 2017Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 feb 2017
    Entregado el 01 mar 2017
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale and Yorkshire Bank) (Company Number SC001111)
    Transacciones
    • 01 mar 2017Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 feb 2017
    Entregado el 01 mar 2017
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale and Yorkshire Bank) (Company Number SC001111)
    Transacciones
    • 01 mar 2017Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 feb 2017
    Entregado el 01 mar 2017
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale and Yorkshire Bank) (Company Number SC001111)
    Transacciones
    • 01 mar 2017Registro de una carga (MR01)
    Debenture
    Creado el 19 nov 2012
    Entregado el 23 nov 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 23 nov 2012Registro de un cargo (MG01)
    Deed of assignment
    Creado el 19 nov 2012
    Entregado el 23 nov 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Assigns with full title guarantee the charged assets being the whole right title and interest in and to the policy together with all rights attaching to the policy numbers L0192689733, 16526198 and 0160610614 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 23 nov 2012Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 19 nov 2012
    Entregado el 22 nov 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all the undertaking, property, assets and rights, including all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties and all equipment. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Ngbi Private Equity Fund Ii LP and M.J. Cole and H.R. Farquhar and Paul Haigney and Susan Davenport
    Transacciones
    • 22 nov 2012Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 14 nov 2009
    Entregado el 24 nov 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 24 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 23 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 14 nov 2009
    Entregado el 18 nov 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Nbgi Private Equity Fund Ii LP
    Transacciones
    • 18 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 23 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene PK FOOD CONCEPTS LTD. algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 ago 2019Inicio de la liquidación
    14 ene 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Francis Graham Newton
    6th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    6th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Simon Edward Jex Girling
    Bdo Llp Bridgewater House Finzels Reach
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Avon
    Profesional
    Bdo Llp Bridgewater House Finzels Reach
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Avon

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0