AGHOCO 1022 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAGHOCO 1022 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 07200489
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AGHOCO 1022 LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra AGHOCO 1022 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor 24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AGHOCO 1022 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AGHOCO 1022 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Modification des détails de Independent Group (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 ene 2023

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Rjp Secretaries Limited como secretario el 25 ene 2023

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Cossey Cosec Services Limited como secretario el 25 ene 2023

    2 páginasAP04

    Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW el 06 ene 2023

    1 páginasAD01

    Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga 072004890008

    5 páginasMR05

    Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga 4

    5 páginasMR05

    Modification des détails de Gold Round Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 jul 2022

    2 páginasPSC05

    Cambio de datos del director Gold Round Limited el 25 jul 2022

    1 páginasCH02

    Declaración de confirmación presentada el 24 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2021

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Stuart Pace el 21 jul 2021

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 24 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2020

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alan Albert Horton como director el 30 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Stuart Pace el 29 jun 2020

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 24 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Gold Round Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2019

    8 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Rjp Secretaries Limited el 09 ago 2019

    1 páginasCH04

    Modification des détails de Independent Group (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 ago 2019

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England a Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL el 12 ago 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 24 may 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de AGHOCO 1022 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COSSEY COSEC SERVICES LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro14344691
    302964180001
    PACE, Stuart
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Director
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish207506130003
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Director corporativo
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro05687325
    149588400001
    ROCKETT, Matthew Ian
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    Secretario
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    British153274690001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2598128
    90084920001
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02989995
    61999120002
    BELL, Jonathan
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    Director
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    EnglandBritish123082590001
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish139480580001
    HART, Roger
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Director
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritish105579880001
    HILLS, Kenneth Cumming
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    United KingdomBritish159009950001
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish182208240001
    LEE, Peter Francis
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish207608120001
    LEES, Stuart
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Director
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    EnglandBritish70032700001
    LLOYD-JONES, Andrew Mark
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish149155620001
    ROCKETT, Matthew Ian
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    Director
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    BritishBritish146169560001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Director
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritish207506140001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Director corporativo
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2598128
    90084920001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Director designado corporativo
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2598228
    900006560001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de AGHOCO 1022 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    24 Old Bond Street
    W1S 4AW Mayfair
    4th Floor
    London
    United Kingdom
    18 abr 2016
    24 Old Bond Street
    W1S 4AW Mayfair
    4th Floor
    London
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05687325
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    06 abr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05687325
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    06 abr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06732498
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene AGHOCO 1022 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 sept 2016
    Entregado el 13 sept 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Blackstar 2016 Limited
    Transacciones
    • 13 sept 2016Registro de una carga (MR01)
    • 17 dic 2022Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    A registered charge
    Creado el 03 jun 2016
    Entregado el 17 jun 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Secure Trust Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 2016Registro de una carga (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Creado el 31 ene 2011
    Entregado el 08 feb 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transacciones
    • 08 feb 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 28 mar 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 26 june 2009
    Creado el 31 ene 2011
    Entregado el 08 feb 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transacciones
    • 08 feb 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 31 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 31 ene 2011
    Entregado el 03 feb 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 03 feb 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 17 dic 2022Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    A composite guarantee and debenture
    Creado el 31 jul 2010
    Entregado el 07 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Evander Limited
    Transacciones
    • 07 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 02 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 10 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Security Trustee)
    Transacciones
    • 10 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 02 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 jul 2010
    Entregado el 05 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 02 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0