BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION
Visión general
Nombre de la empresa | BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
Número de empresa | 07355605 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION?
- Actividades de organizaciones de miembros empresariales y de empleadores (94110) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION?
Dirección de la sede social | C/O Rsm Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent Staffs England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION LIMITED | 13 sept 2010 | 13 sept 2010 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 09 ago 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 23 ago 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 09 ago 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Alan Thomas Grieve Dodds como director el 31 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Dr Helene Elizabeth Roberts como director el 17 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Allen Tutton como director el 17 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Forbes como director el 17 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Lisa Whitfield como director el 25 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Eldred Robinson como director el 25 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 ago 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Rsm Festival Way Festival Park Stoke-on-Trent Staffs ST1 5BB England a C/O Rsm Festival Way Festival Park Stoke-on-Trent Staffs ST1 5BB el 17 ago 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 27 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin William Gates como director el 27 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Margaret Ann Talbot como director el 27 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Gahir como director el 27 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Forbes como director el 27 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Julie Mclean como director el 25 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jennifer Cassidy como director el 25 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 09 ago 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Christopher Davis como director el 06 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Geoffrey Sigmund Gestetner como director el 06 jun 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Michael Mcentee como director el 06 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Brent William Hudson como director el 06 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKER, Craig | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | England | British | Managing Director | 261075180001 | ||||
DAVIS, Peter Christopher | Director | Edgehill Drive CV34 6NH Warwick Geberit House England | England | British | Managing Director | 297018940001 | ||||
GAHIR, Michael | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | England | British | Managing Director | 273945110001 | ||||
GESTETNER, Geoffrey Sigmund | Director | Woodley Park Estate 59-69 Reading Road RG5 3AN Woodley Unit 1 Berkshire England | England | British | Company Director | 47136960002 | ||||
MCLEAN, Julie | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | United Kingdom | British | Marketing Director | 309932880001 | ||||
OSBORNE, David Charles | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | England | British | Managing Director | 52369470003 | ||||
PARKER, Jason James | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | England | British | Managing Director | 260860460001 | ||||
REYNOLDS, Thomas Anthony William | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | England | British | Chief Executive | 263275590001 | ||||
ROBERTS, Helene Elizabeth, Dr | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | England | British | Managing Director | 181771740001 | ||||
THOMPSON, John Antony | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | England | British | Director | 288336440001 | ||||
WHITFIELD, Lisa | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | United Kingdom | British | Managing Director | 309276070001 | ||||
CASSIDY, Jennifer | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent Rsm Staffs England | Scotland | British | Chief Marketing Officer At Bristan Group Ltd | 288391830001 | ||||
DODDS, Alan Thomas Grieve | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | United Kingdom | British | Managing Director | 191160470001 | ||||
FORBES, Stephen | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | United Kingdom | British | Managing Director | 301971700001 | ||||
GATES, Kevin William | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent Rsm Staffs England | England | British | Managing Director | 90475360001 | ||||
HILL, Richard Graham | Director | 1 Keele Science And Business Park Keele ST5 5NB Newcastle Innovation Centre Staffordshire | England | British | Solicitor | 47331700001 | ||||
HUDSON, Brent William | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent Rsm Staffs England | England | British | Product & Technical Director | 191682470001 | ||||
LEE, Stephen John Spencer | Director | 1 Keele Science And Business Park Keele ST5 5NB Newcastle Innovation Centre Staffordshire | England | British | Company Director | 116447380004 | ||||
LEE, Stephen John Spencer | Director | Keele Science And Business Park Keele ST5 5NB Newcastle Under Lyme Innovation Centre 1 Staffordshire England | United Kingdom | British | Company Director | 174234690001 | ||||
MASSEY, Paul Albert | Director | Keele Science And Business Park Keele ST5 5NB Newcastle-Under-Lyne Innovation Centre 1 Staffordshire | England | British | Group Ceo Manufacturing | 75834240001 | ||||
MCENTEE, Peter Michael | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent Rsm Staffs England | England | British | Territory Manager | 260860910001 | ||||
MCGRELLIS, Nicholas Edward | Director | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | England | British | Managing Director | 204148800001 | ||||
NORCUP, Liam | Director | Station Road ST4 2RT Stoke-On-Trent Federation House Staffordshire | England | British | Trainee Solicitor | 153609350001 | ||||
ORGILL, Yvonne | Director | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | England | British | Trade Association Chief Executive | 137982270001 | ||||
ROBINSON, John Eldred | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | England | British | Business Director | 248603110001 | ||||
SMITH, Jason Neill | Director | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | England | British | Chief Commercial Officer | 149186360003 | ||||
STUART, Ian | Director | Keele Science And Business Park Keele ST5 5NB Newcastle Under Lyme Innovation Centre 1 Staffordshire England | United Kingdom | British | Director | 95599700001 | ||||
TALBOT, Margaret Ann | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent Rsm Staffs England | England | British | Marketing Manager | 284829380001 | ||||
TUTTON, David Allen | Director | Festival Way Festival Park ST1 5BB Stoke-On-Trent C/O Rsm Staffs England | England | British | Managing Director | 165023790002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Mr Thomas Anthony William Reynolds | 09 oct 2019 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Brent William Hudson | 26 jun 2019 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Jason James Parker | 26 jun 2019 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Craig Baker | 26 jun 2019 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Kevin William Gates | 26 jun 2019 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr David Allen Tutton | 26 jun 2019 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Jason Neill Smith | 26 jun 2019 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Peter Michael Mcentee | 25 jun 2019 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr John Eldred Robinson | 20 jun 2018 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr David Charles Osborne | 06 abr 2016 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Alan Thomas Grieve Dodds | 06 abr 2016 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
Mrs Yvonne Orgill | 06 abr 2016 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Nicholas Edward Mcgrellis | 06 abr 2016 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffordshire England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Paul Albert Massey | 06 abr 2016 | Innovation Way Keele University Science & Innovation Park, Keele ST5 5NT Newcastle-Under-Lyme Innovation Centre 5 Staffs England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BATHROOM MANUFACTURERS ASSOCIATION?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
27 feb 2020 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0