AURORA LIVING LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | AURORA LIVING LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 07444737 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AURORA LIVING LTD?
- Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción
¿Dónde se encuentra AURORA LIVING LTD?
| Dirección de la sede social | C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AURORA LIVING LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MAR CITY HOMES LIMITED | 01 dic 2010 | 01 dic 2010 |
| TERNGATE LIMITED | 18 nov 2010 | 18 nov 2010 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AURORA LIVING LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AURORA LIVING LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores | 23 páginas | LIQ14 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 08 feb 2022 | 20 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 17 feb 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 05 sept 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN el 02 jul 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de asuntos | 10 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor Ts1, Pinewood Business Park Coleshill Road Marston Green, Solihull Birmingham B37 7HG England a C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ el 01 mar 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 28 jun 2019 au 27 jun 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Matthew Underwood como director el 29 may 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2019 au 28 jun 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Registro de la carga 074447370007, creada el 18 nov 2019 | 10 páginas | MR01 | ||||||||||
Registro de la carga 074447370006, creada el 03 ene 2019 | 10 páginas | MR01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de AURORA LIVING LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK, Robert James | Secretario | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | 244719140001 | |||||||
| EVERETT, Martyn John | Director | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | England | British | 30098070003 | |||||
| PICK, Robert James | Director | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited West Midlands | England | British | 244612380001 | |||||
| DAVIES, Christopher | Secretario | Coleshill Road Marston Green, Solihull B37 7HG Birmingham Ground Floor Ts1, Pinewood Business Park England | 224547770001 | |||||||
| HOLDER, John Edwin | Secretario | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands | British | 188782110001 | ||||||
| HUNT, Brian William | Secretario | Stratford Road Shirley B90 4EE Solihull 1036 West Midlands United Kingdom | 164117990001 | |||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Coleshill Road Marston Green, Solihull B37 7HG Birmingham Ground Floor Ts1, Pinewood Business Park England | 199416530001 | |||||||
| STYLES, Andrew Timothy | Secretario | Coleshill Road Marston Green, Solihull B37 7HG Birmingham Ground Floor Ts1, Pinewood Business Park England | 208518050001 | |||||||
| ANSTEAD, Hamilton Douglas | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands England | England | British | 135042210001 | |||||
| ASHWOOD, Nigel | Director | Stratford Road Shirley B90 4EE Solihull 1036 West Midlands United Kingdom | England | British | 170860190001 | |||||
| CLARKE, Antony Charles | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands England | England | British | 180655700001 | |||||
| DAVIES, Richard Llewelyn | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands England | England | British | 180657810001 | |||||
| GRADY, Mark | Director | Stratford Road Shirley B90 4EE Solihull 1036 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 71141850001 | |||||
| GRIMSHAW, Peter Edward | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands England | United Kingdom | British | 97632020001 | |||||
| HOLDER, John Edwin | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands | England | British | 75167510001 | |||||
| INSKIP, Wayne | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands | England | British | 193894760001 | |||||
| KING, John Anthony | Director | Holywell Row EC2A 4JB London 27 United Kingdom | United Kingdom | British | 62812060002 | |||||
| MUIR, Andrew Thomas | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands England | England | British | 113276610001 | |||||
| MURPHY, Craig Douglas | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands | United Kingdom | British | 194138910001 | |||||
| RYAN, Margaret Anne | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands England | United Kingdom | Irish | 157027330001 | |||||
| RYAN, Patrick Anthony | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands England | United Kingdom | Irish | 164117180001 | |||||
| SAMBROOKS, Paul Richard | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands England | England | British | 84170250001 | |||||
| STYLES, Andrew Timothy | Director | Coleshill Road Marston Green, Solihull B37 7HG Birmingham Ground Floor Ts1, Pinewood Business Park England | United Kingdom | British | 201518450001 | |||||
| SUMMERS, David William | Director | Coleshill Road Marston Green, Solihull B37 7HG Birmingham Ground Floor Ts1, Pinewood Business Park England | United Kingdom | British | 193894830001 | |||||
| TYLER, Derrick | Director | Great Hampton Street Hockley B18 6ES Birmingham 113 115 West Midlands | United Kingdom | British | 101205940003 | |||||
| UNDERWOOD, Paul Matthew | Director | Coleshill Road Marston Green, Solihull B37 7HG Birmingham Ground Floor Ts1, Pinewood Business Park England | England | British | 201517490001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AURORA LIVING LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar City Plc | 06 abr 2016 | Coleshill Road Marston Green B37 7HG Birmingham Ground Floor Ts1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene AURORA LIVING LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 18 nov 2019 Entregado el 27 nov 2019 | Pendiente | ||
Breve descripción Land lying to the north of needwood, grove, west bromwich registered at the land registry with title number WM965874. Land at needwood grove, west bromwich registered at the land registry with title number WM965987. Land lying to the north of campville crescent, west bromwich registered at the land registry with title number WM968772. Land on the north west side of 102 hall green road, west bromwich B71 3LB registered at the land registry with title number WM973043.. All such rights, title and interest in the unregistered freehold parcel of land situate at hall green road, west bromwich, to the rear of 102 hall green road as compromised within a transfer dates on or around the date hereof and made between (1) the borough council sandwell and (2) aurora living limited. Contiene una promesa negativa: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 03 ene 2019 Entregado el 11 ene 2019 | Pendiente | ||
Breve descripción Freehold land known as multi purpose centre, victoria road, wednesbury WS10 8AP registered at the land registry with title number WM896377. Contiene una promesa negativa: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 15 oct 2015 Entregado el 20 oct 2015 | Pendiente | ||
Breve descripción The unregistered leasehold properties being garages no.106, No.107, No.108 And no.10, Alexandra grange, tipton, west midlands. Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 17 dic 2014 Entregado el 19 dic 2014 | Pendiente | ||
Breve descripción 1036 -1048 strafford road, shirley, title numbers: WK149491, WK217798, WK182336, WK115831, WM295679. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 11 sept 2014 Entregado el 12 sept 2014 | Pendiente | ||
Breve descripción Freehold land at zurich house, east park, crawley RH10 6AN registered at the land registry with title number WSX69814. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 11 ago 2014 Entregado el 13 ago 2014 | Pendiente | ||
Breve descripción Freehold land known as land at hall green road, sandwell west bromwich registered at the land registry with title number WM574333. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 31 jul 2014 Entregado el 04 ago 2014 | Pendiente | ||
Breve descripción Land to the north side of cranford street, smethwick, west midlands, B66 2RX registered at the land registry with the following title numbers WM363502, WM694377, WM664410, WM528115, WM517594 and MM19185 and additional land – please see deed for further details. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene AURORA LIVING LTD algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0