WOODBURY RESIDUAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WOODBURY RESIDUAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 07472957 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WOODBURY RESIDUAL LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra WOODBURY RESIDUAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3mc Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry West Midlands United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WOODBURY RESIDUAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| QUANTEL HOLDINGS LIMITED | 19 may 2011 | 19 may 2011 |
| QUANTEL HOLDINGS (2010) LIMITED | 17 dic 2010 | 17 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WOODBURY RESIDUAL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WOODBURY RESIDUAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul John Horton como director el 25 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul John Horton como director el 26 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 45 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Knight como director el 31 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 074729570003 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Rupert Staveley-Smith como director el 20 ago 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Mark Peter Adcock como director el 20 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Knight como director el 08 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Anthony Maycock como director el 08 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Willem Szabo-Rowe como director el 08 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Hurley como director el 08 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul John Horton como director el 08 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Eric Cooney como director el 08 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Turnpike Road Newbury Berkshire RG14 2NX a 3Mc Middlemarch Business Park Siskin Drive Coventry West Midlands CV3 4FJ el 04 abr 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 074729570005, creada el 08 feb 2018 | 45 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WOODBURY RESIDUAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGGETT, Kevan Paul | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | England | British | 110404770001 | |||||||||
| STAVELEY-SMITH, Simon Rupert | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | England | British | 249651370001 | |||||||||
| COOPER, Ian Graham | Secretario | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | British | 166179150001 | ||||||||||
| OVALSEC LIMITED | Secretario corporativo | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 United Kingdom |
| 149653060001 | ||||||||||
| ADCOCK, Simon Mark Peter | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | England | British | 204418500001 | |||||||||
| COONEY, Eric | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | United States | American | 233949460001 | |||||||||
| COOPER, Ian Graham | Director | Turnpike Road RG14 2NE Newbury 31 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 186068780001 | |||||||||
| CROSS, Ray John | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 186071160001 | |||||||||
| EALES, Darryl Charles | Director | Vine Street W1J 0AH London 1 England | England | British | 154807060001 | |||||||||
| EATON, Guy Frederick St John | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | England | British | 150889170002 | |||||||||
| HORTON, Paul John | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 169898500001 | |||||||||
| HORTON, Paul John | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 169898500001 | |||||||||
| HURLEY, Christopher | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | England | British | 195559240001 | |||||||||
| KNIGHT, Stephen | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | England | British | 245553050001 | |||||||||
| KNIGHT, Stephen Richard | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | England | British | 201628270001 | |||||||||
| MARTIN, Paul Graham | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | England | British | 166222610001 | |||||||||
| MAYCOCK, Neil Anthony | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | England | British | 210272790001 | |||||||||
| MULLIGAN, Martin | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | England | British | 66989250001 | |||||||||
| OWEN, Stephen John | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | Uk | British | 165973880001 | |||||||||
| ROGERS, Simon Darryl | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 136810060003 | |||||||||
| ROWE, Robert | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | England | British | 191622460001 | |||||||||
| SZABO-ROWE, Robert Willem | Director | Middlemarch Business Park Siskin Drive CV3 4FJ Coventry 3mc West Midlands United Kingdom | England | British | 210275040002 | |||||||||
| THORSTEINSON, Timothy Edward | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire | Canada | Canadian/American | 195613520001 | |||||||||
| OVAL NOMINEES LIMITED | Director corporativo | Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol 2 United Kingdom |
| 150051910001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WOODBURY RESIDUAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ldc (Managers) Ltd | 06 abr 2016 | Vine Street W1J 0AH London 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene WOODBURY RESIDUAL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 08 feb 2018 Entregado el 12 feb 2018 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 26 ago 2016 Entregado el 05 sept 2016 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 30 dic 2015 Entregado el 08 ene 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Not applicable. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 11 mar 2014 Entregado el 27 mar 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Land on the north west side of cutbush close, lower earley, reading t/no BK262688. Land on the north west side of cutbush close, lower earley, reading t/no BK222477. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 abr 2011 Entregado el 09 abr 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0