JUPITER ACQUISITIONS LIMITED

JUPITER ACQUISITIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJUPITER ACQUISITIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 07577857
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JUPITER AQUISITIONS LIMITED24 mar 201124 mar 2011

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 dic 2021

    9 páginasLIQ03

    Cese del nombramiento de David Huw Griffiths como director el 02 mar 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY

    2 páginasAD02

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 17 dic 2020

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF el 04 ene 2021

    2 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Pablo Andres como director el 01 nov 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Daniel Joseph Guerin como director el 31 oct 2020

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mark Richard Jones el 25 sept 2020

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Daniel Joseph Guerin el 25 sept 2020

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr David Huw Griffiths el 25 sept 2020

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Morton Fraser Llp St Martin's House 16 st Martins Le Grand London EC1A 4EN a Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY el 25 sept 2020

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Mobius Wind Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 sept 2020

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Morton Fraser Secretaries Limited como secretario el 25 sept 2020

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Burness Paull Llp como secretario el 25 sept 2020

    2 páginasAP04

    Nombramiento de Mr Daniel Joseph Guerin como director el 01 ene 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mark Richard Jones como director el 01 ene 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 29 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de David Mel Zuydam como director el 01 ene 2020

    1 páginasTM01

    Notification de Mobius Wind Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 ago 2019

    2 páginasPSC02

    Cessation de Jupiter Acquisitions (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 ago 2019

    1 páginasPSC07

    ¿Quiénes son los directivos de JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BURNESS PAULL LLP
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Secretario corporativo
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Forma jurídicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo de identificaciónOtra entidad corporativa o firma
    Autoridad legalSCOTLAND, SCOTS LAW
    Número de registroSO300380
    274632090001
    ANDRES, Pablo
    12 Blenheim Place
    EH7 5JH Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Director
    12 Blenheim Place
    EH7 5JH Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish276031210001
    JONES, Mark Richard
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    ScotlandBritish254843030001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Secretario
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    201246140001
    BISSET, Graham Ferguson
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Secretario
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    Northamptonshire
    United Kingdom
    194566770001
    CALDER, Samantha Jane
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    Secretario
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    British75830790003
    LONG, Jacqueline
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    United Kingdom
    Secretario
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    United Kingdom
    204213400001
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    2 Lister Square
    Quartermile Two
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor
    Scotland
    Secretario corporativo
    2 Lister Square
    Quartermile Two
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC262093
    95512800001
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    England
    Director
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    England
    EnglandBritish294355310001
    BOYD, Gordon Alexander
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    Director
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    EnglandBritish148856600001
    BROWN, Katerina
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    Director
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    ScotlandBritish232165890001
    GIBBINS, Stewart Charles
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    England
    Director
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    England
    United KingdomBritish148918290002
    GREGSON, Paul Jonathan
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    Director
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    EnglandBritish154908310001
    GRIFFITHS, David Huw
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomBritish177733400003
    GUERIN, Daniel Joseph
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Director
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    EnglandIrish210311660001
    HARDMAN, Steven Neville
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    Director
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    UkBritish93743250007
    HINTON, Thomas Edward
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Director
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    United KingdomBritish238940970001
    LEE, Andrew William
    St. Martin's House
    16 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United Kingdom
    Director
    St. Martin's House
    16 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish87527870001
    MACHIELS, Eric Philippe Marianne
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    Director
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    EnglandBelgian125748990002
    MACKENZIE, Scott Leitch
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    Director
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United KingdomBritish277478140001
    NAGLE, Michael
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    Director
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United KingdomBritish29436380007
    PICKERING, Stephen Shane
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Director
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    United KingdomBritish198076630001
    WALTERS, Mark Alan
    Victoria Embankment
    EC4Y 0JP London
    60
    United Kingdom
    Director
    Victoria Embankment
    EC4Y 0JP London
    60
    United Kingdom
    EnglandBritish317548840001
    WINTER, Robert Guy Stewart
    10 St Paul's Churchyard
    EC4M 8AL London
    Condor House
    England
    Director
    10 St Paul's Churchyard
    EC4M 8AL London
    Condor House
    England
    EnglandBritish158816660001
    ZUYDAM, David Mel
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    Director
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    EnglandBritish259635370001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mobius Wind Holdings Limited
    133-137 Alexandra Road
    Wimbledon
    SW19 7JY London
    Connect House
    United Kingdom
    15 ago 2019
    133-137 Alexandra Road
    Wimbledon
    SW19 7JY London
    Connect House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro07086998
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    06 abr 2016
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07578959
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene JUPITER ACQUISITIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 18 dic 2017
    Entregado el 20 dic 2017
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 2017Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 15 dic 2017
    Entregado el 29 dic 2017
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC, 4TH Floor, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9PE, United Kingdom as Security Trustee (As Trustee for Each of the Secured Creditors)
    Transacciones
    • 29 dic 2017Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 10 oct 2013
    Entregado el 17 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 17 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 18 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 10 oct 2013
    Entregado el 17 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 17 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 18 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 10 oct 2013
    Entregado el 17 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 17 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 18 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 09 oct 2013
    Entregado el 11 oct 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 12 dic 2017Todo el bien o empresa ha sido liberado y ya no forma parte de la carga (MR05)
    A registered charge
    Creado el 09 oct 2013
    Entregado el 11 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 18 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of pledge
    Creado el 14 abr 2011
    Entregado el 03 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from minsca windfarm (scotland) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The secured assets being the existing shares, the further shares and the related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of pledge
    Creado el 14 abr 2011
    Entregado el 21 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The secured assets being the existing shares, the future shares and the related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of pledge
    Creado el 14 abr 2011
    Entregado el 21 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from dalswinton windfarm (scotland) limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The secured assets being the existing shares, the future shares and the related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over shares
    Creado el 14 abr 2011
    Entregado el 19 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed charge any shares and any rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 19 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 13 dic 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over shares
    Creado el 14 abr 2011
    Entregado el 19 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed charge the shares and any rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Securtiy Trustee")
    Transacciones
    • 19 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 13 dic 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over shares
    Creado el 14 abr 2011
    Entregado el 19 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The shares in slieve divena wind farm limited and any rights including dividends, see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 19 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 abr 2011
    Entregado el 15 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from minsca windfarm (scotland) limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all copyright, plant and machinery, the specified key accounts. See image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 abr 2011
    Entregado el 15 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all copyright, plant and machinery, the specified key accounts. See image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 abr 2011
    Entregado el 15 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from dalswinton windfarm (scotland) limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all copyright, plant and machinery, the specified key accounts. See image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 17 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene JUPITER ACQUISITIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    12 mar 2023Fecha prevista de disolución
    17 dic 2020Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Matthew Coomber
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0