THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 07902965 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED?
- Actividades de sociedades holding de servicios financieros (64205) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Brennan House Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 feb 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 mar 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 feb 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2025 | 19 páginas | AA | ||
legacy | 58 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 feb 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Andy Thompson el 03 ago 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Registro de la carga 079029650003, creada el 13 oct 2025 | 36 páginas | MR01 | ||
legacy | 57 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2024 | 20 páginas | AA | ||
legacy | 57 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Cambio de datos del director Mr Darren William John Sharkey el 22 feb 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Andy Thompson el 22 feb 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Registro de la carga 079029650002, creada el 29 nov 2024 | 36 páginas | MR01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 jun 2023 | 21 páginas | AA | ||
legacy | 53 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 53 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDTHORPE, Simon Timothy | Director | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | British | 14508630008 | |||||
| SHARKEY, Darren William John | Director | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | Irish | 50612110035 | |||||
| THOMPSON, Andrew Bernard | Director | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | United Kingdom | British | 299614380002 | |||||
| CHARD, Nicola Ruth | Secretario | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire Uk | 165753370001 | |||||||
| JARDINE, Jacqueline | Secretario | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire | 171818040002 | |||||||
| SNASHFOLD, Sandra Lee | Secretario | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire | 181493710001 | |||||||
| BALKHAM, Shane Michael | Director | Nutfield Road RH1 3HA Merstham 78 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 128186970001 | |||||
| BENNETT, Andrew John | Director | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | British | 167934380001 | |||||
| BILLINGHAM, Philip Leonard | Director | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | England | British | 58337260008 | |||||
| CHARD, Nicola Ruth | Director | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire Uk | United Kingdom | British | 96229310002 | |||||
| DUNNE, Derrick William | Director | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | British | 92454160002 | |||||
| EASTER, Alan James | Director | Marline Court Little High Street BH43 5EQ Shoreham By Sea 29 United Kingdom | United Kingdom | British | 167936610001 | |||||
| GOLDTHORPE, Clive Simon | Director | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | England | British | 152101520005 | |||||
| GRAINGER, Paul Timothy | Director | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | England | Irish | 217625630001 | |||||
| INGRAM, David John | Director | Green Lane Heatons Moor SK4 3LH Stockport 79 Cheshire United Kingdom | England | British | 154583950001 | |||||
| JARDINE, Jacqueline | Director | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Portugal | British | 195697240010 | |||||
| JARDINE, Jacqueline | Director | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire | England | British | 152279920002 | |||||
| SNASHFOLD, Sandra Lee | Director | 85-87 Basingstoke Road RG2 0HA Reading Beaufort House Berkshire | England | British | 141604910001 | |||||
| SWANSTON, Jade Marie | Director | Farnborough Aerospace Centre Business Park GU14 6XR Farnborough Brennan House United Kingdom | England | British | 279571720001 | |||||
| WATSON, Stephen Grant | Director | Riverside Way GU15 3YL Camberley Building 2 England | England | British | 96296070001 | |||||
| WILLIAMS, Peter John, Dr | Director | Chestnut Close Horbury WF4 5QF Wakefield 1 Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 166319680001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE BEAUFORT GROUP OF COMPANIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finli Advice Holdings Limited | 30 jun 2023 | Davy Avenue Knowlhill MK5 8HJ Milton Keynes C/O Freeths Llp Routeco Office Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| James Christopher Flowers | 03 ago 2022 | 767 Fifth Avenue 10153 New York 23rd Floor Ny United States | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mrs Jade Marie Swanston | 27 ene 2021 | Riverside Way GU15 3YL Camberley Building 2 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Derrick William Dunne | 27 ago 2020 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Paul Timothy Grainger | 01 nov 2018 | Riverside Way GU15 3YL Camberley Building 2 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Irish País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Marlborough Group Holdings Limited | 24 ene 2018 | Chorley New Road BL1 4QP Bolton Marlborough House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Stephen Grant Watson | 06 abr 2016 | Riverside Way GU15 3YL Camberley Building 2 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mrs Jacqueline Jardine | 06 abr 2016 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Clive Simon Goldthorpe | 06 abr 2016 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Simon Timothy Goldthorpe | 06 abr 2016 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Andrew John Bennett | 06 abr 2016 | High Street RH1 1SH Redhill Fourth Floor, Kingsgate Surrey United Kingdom | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0