MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD

MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 07983197
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Dirección de la sede social
    Suez House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SITA SEMBCORP UK HOLDINGS LIMITED26 jun 201326 jun 2013
    SHUKCO 312 LIMITED09 mar 201209 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta08 mar 2027
    Próxima declaración de confirmación vence22 mar 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta08 mar 2026
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Modification des détails de Suez Recycling and Recovery Uk Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Cessation de Sembcorp Utilities (Pte) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC07

    Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2026 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr. Richard Geoffrey Little como director el 30 nov 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Daniel Geoffrey North como director el 30 nov 2025

    1 páginasTM01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2025

    38 páginasAA

    Cese del nombramiento de Philip Bruce Sheffer como director el 25 abr 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr. David Anthony Morris como director el 07 may 2025

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2025 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr. Iqbal Singh Sidhu el 20 feb 2025

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr. Iqbal Singh Sidhu como director el 20 feb 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Thomas Patrick como director el 20 feb 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr. Philip Bruce Sheffer como director el 20 feb 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew John Cottrell como director el 31 dic 2024

    1 páginasTM01

    Notification de Semperian Ppp Investment Partners No.2 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 ago 2024

    2 páginasPSC02

    Notification de Sembcorp Utilities (Pte) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Notification de Suez Recycling and Recovery Uk Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 16 oct 2024

    2 páginasPSC09

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2024

    38 páginasAA

    Nombramiento de Mr. Daniel North como director el 15 ago 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr. Neil Rae como director el 15 ago 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kazuma Fukao como director el 15 ago 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Rahul Dipinkumar Kadiwar como director el 15 ago 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr. Andrew John Cottrell como director el 01 dic 2023

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK LTD
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Secretario corporativo
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02291198
    114869260003
    LITTLE, Richard Geoffrey, Mr.
    4th Floor
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian
    England
    Director
    4th Floor
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian
    England
    EnglandBritish151062990002
    MORRIS, David Anthony, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Director
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish335522840001
    PADFIELD, Amanda
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish159090300001
    RAE, Neil, Mr.
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Director
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    United KingdomBritish119437600003
    SIDHU, Iqbal Singh, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Director
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    United KingdomBritish332910240001
    THOMPSON, Mark Hedley
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish162837220002
    THORN, Christopher Derrick
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish266799220001
    KNIGHT, Joan
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Secretario
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    167385630001
    AHMAD, Nauman
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandPakistani246516040001
    ANNAN, Douglas Stuart, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish165609970001
    BONE, Dugald John, Dr
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Director
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    EnglandBritish84834380001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandFrench122645500003
    CHONG, Kwong Fatt
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Director
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    SingaporeSingaporean183833580001
    COTTRELL, Andrew John
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Director
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    United KingdomBritish334057500001
    FUKAO, Kazuma
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Director
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese308897090001
    GAVIN, Paul
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish159027960001
    HANDS, Stephen Christopher
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Director
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    EnglandBritish205116300001
    HIBINO, Tsuneharu
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandJapanese168730210001
    HIGASHIYAMA, Eiichiro
    The Broadgate Tower, 20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd
    England
    Director
    The Broadgate Tower, 20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd
    England
    EnglandJapanese195916850001
    KADIWAR, Rahul Dipinkumar
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower
    England
    Director
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish313395690001
    KANAI, Masashi
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Director
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese282813470002
    KNOX, Belinda Faith
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Director
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish190578640001
    MCCLAY, Catherine Isabel, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish245734420001
    MCKENNA-MAYES, Graham Arthur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish91435430011
    NG, Meng Poh
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    SingaporeSingaporean150975730001
    NORTH, Daniel Geoffrey
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Director
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    EnglandBritish259587080001
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish125070620001
    PATRICK, Michael Thomas
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    Director
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritish293354340001
    SCRIMSHAW, Matthew Giles
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish265146200001
    SEXTON, Ian Anthony
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Director
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    FranceBritish182259120001
    SHEFFER, Philip Bruce, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Director
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish332909490001
    SUZUKI, Yuji
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Director
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese236854110002
    THOMPSON, David Keith
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    Director
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritish265146580001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Gresham Street
    4th Floor
    EC2V 7BX London
    1
    England
    15 ago 2024
    Gresham Street
    4th Floor
    EC2V 7BX London
    1
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act, 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06250753
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    06 abr 2016
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02291198
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Sembcorp Utilitied Pte Limited
    Hill Street
    No 05-04
    Singapore, 179360
    30
    Singapore
    06 abr 2016
    Hill Street
    No 05-04
    Singapore, 179360
    30
    Singapore
    Forma jurídicaPublic Company Limited By Shares
    País de registroSingapore
    Autoridad legalCompanies Act Chapter 50
    Lugar de registroSingapore
    Número de registro197300648h
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Sembcorp Utilities (Pte) Limited
    Hill Street
    #05-04
    179360
    Singapore
    30
    Singapore
    06 abr 2016
    Hill Street
    #05-04
    179360
    Singapore
    30
    Singapore
    Forma jurídicaCompany
    País de registroSingapore
    Autoridad legalCompanies Act 1967
    Lugar de registroAcra
    Número de registro197300648h
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    England
    06 abr 2016
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act, 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02291198
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    17 oct 201916 oct 2024La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0