KC (SPH) GP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KC (SPH) GP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 12305611 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KC (SPH) GP LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra KC (SPH) GP LIMITED?
| Dirección de la sede social | 12.01 The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KC (SPH) GP LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para KC (SPH) GP LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 07 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 21 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 07 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KC (SPH) GP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Sarah Brown como secretario el 11 mar 2026 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Lydia Florinette Gabrielle Harratt como secretario el 11 mar 2026 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Stephane Jalbert como director el 23 feb 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Matthew James Fidge como director el 23 feb 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de David Scudder como secretario el 05 ene 2026 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Lydia Florinette Gabrielle Harratt como secretario el 05 ene 2026 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Nicholas Charles Deacon como director el 31 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 59 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de 4 Stable Street London England and Wales N1C 4AB United Kingdom a 12.01 the Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street London N1C 4EW el 05 sept 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del secretario David Scudder el 13 ago 2025 | 1 páginas | CH03 | ||
Cambio de datos del director Leo Shapland el 13 ago 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de King's Cross Central General Partner Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 jul 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Nombramiento de Mr Carl Anthony Astorri como director el 21 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Carl Anthony Astorri como director el 04 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Ms Julie Celine Hirigoyen el 09 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Caroline Sheila Wehrle el 09 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Carl Anthony Astorri como director el 01 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mrs Caroline Sheila Wehrle como director el 01 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Julie Celine Hirigoyen como director el 01 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de William Joseph Gibby como director el 01 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Emily Clare Bird como director el 01 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Leo Shapland como director el 29 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Modification des détails de King's Cross Central General Partner Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cese del nombramiento de Coline Lucille Mcconville como director el 24 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de KC (SPH) GP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Sarah | Secretario | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | 346279900001 | |||||||
| ASTORRI, Carl Anthony | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | United Kingdom | British | 312053820002 | |||||
| BEDNALL, Jane | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | England | British | 208043180001 | |||||
| CLARK, Paul Richard | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | United Kingdom | British | 94373770001 | |||||
| FIDGE, Matthew James | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | Northern Ireland | Australian | 330122500001 | |||||
| GIBBY, William Joseph | Director | 150 Cheapside EC2V 6ET London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 335314240001 | |||||
| HIRIGOYEN, Julie Celine | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | United Kingdom | British | 300273120001 | |||||
| HUBBARD, Stephen Arthur | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | United Kingdom | British | 223391720001 | |||||
| JALBERT, Stephane | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | United Kingdom | English | 314983440001 | |||||
| SHAPLAND, Leo | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | United Kingdom | British | 335286450001 | |||||
| TAYLOR, Christopher Mark | Director | 150 Cheapside EC2V 6ET London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 159396060002 | |||||
| WEHRLE, Caroline Sheila | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | United Kingdom | British | 164529750001 | |||||
| HARRATT, Lydia Florinette Gabrielle | Secretario | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | 344041100001 | |||||||
| SCUDDER, David | Secretario | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | 264195030001 | |||||||
| ASTORRI, Carl Anthony | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 312053820002 | |||||
| BERGER, Daniel Mark | Director | Lonsdale Street VIC 3000 Melbourne 33/50 Australia | Australia | Australian | 199695520001 | |||||
| BIRD, Emily Clare | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 297162160001 | |||||
| CLEMENTI, Sir David Cecil, Sir | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England England | United Kingdom | British | 270357310001 | |||||
| COLTHORPE, William John Lumsden | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 211274560001 | |||||
| DARROCH, Christopher Raymond Andrew | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | Scotland | British | 81530460007 | |||||
| DEACON, Nicholas Charles | Director | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | United Kingdom | British | 204491550001 | |||||
| DOUGHTY, Stuart John | Director | King's Cross N1C 4AG London Level 3/2 Pancras Square United Kingdom | United Kingdom | British | 31394540001 | |||||
| EVANS, Robert Michael | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 99016100003 | |||||
| FREEMAN, Peter Geoffrey | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 11621550018 | |||||
| GIBBS, Andre | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 99016080056 | |||||
| GIBBS, Andre | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 99016080056 | |||||
| LIGHTBOUND, Michael Bernard | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 172186960003 | |||||
| LIGHTBOUND, Michael Bernard | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 172186960003 | |||||
| MCCONVILLE, Coline Lucille, Ms. | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | Australian | 163576580006 | |||||
| PARTRIDGE, David John Gratiaen | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 41215410027 | |||||
| RUSSELL, Mark Stuart | Director | 150 Cheapside EC2V 6ET London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 283317550001 | |||||
| SEARL, Nicholas Paul | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 172186980001 | |||||
| SEARL, Nicholas Paul | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 172186980001 | |||||
| STRONGMAN, Anna | Director | Stable Street N1C 4AB London 4 England And Wales United Kingdom | England | British | 209776630001 | |||||
| WILMAN, Kirsty Ann-Marie | Director | 150 Cheapside EC2V 6ET London 6th Floor United Kingdom | England | British | 155163600003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KC (SPH) GP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The King's Cross Group Gp Limited | 08 nov 2019 | The Jellicoe Building 5 Beaconsfield Street N1C 4EW London 12.01 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0