J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.
Visión general
| Nombre de la empresa | J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. |
|---|---|
| Estado de la empresa | Convertida/Cerrada |
| Forma jurídica | Sociedad extranjera |
| Número de empresa | FC010020 |
| Jurisdicción | Reino Unido |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Dónde se encuentra J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Dirección de la sede social | 270 Park Avenue New York New York Ny10017 United States |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MORGAN GUARANTY LIMITED | 27 jun 1979 | 27 jun 1979 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. es una empresa extranjera
| Requisitos contables de la sociedad extranjera | |
|---|---|
| Tipo de cuenta extranjera | No se aplican los requisitos contables del país de origen |
| Condiciones de publicación de las cuentas | Fecha de referencia contable asignada por Companies House |
| Actividad comercial | Securities Business & Arranging Interest Rate Swaps |
| Forma jurídica | Limited Liability |
| Es una entidad de crédito o financiera | No |
| Regido por | State Of Delaware, Usa |
| País de registro de origen | UNITED STATES |
| Lugar de registro | Office Of Secretary Of State, State Of Delaware |
| Número de empresa | N/A |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cierre del establecimiento en el Reino Unido BR001994 y de la empresa extranjera FC010020 el 26 may 2017 | 2 páginas | OSDS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 13 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Timothy James Osborne Throsby como director el 05 sept 2016 | 2 páginas | OSTM01 | ||
Nombramiento de David Alan Thompson como persona autorizada para aceptar notificaciones para el establecimiento en el Reino Unido BR001994 el 26 feb 2016. | 2 páginas | OSAP07 | ||
Cese del nombramiento para un establecimiento del Reino Unido - Transaction OSTM03- BR001994 Person Authorised to Accept terminated 26/02/2016 yeng yeng maxwell | 2 páginas | OSTM03 | ||
Nombramiento de Abdelfater Belbachir como director el 14 dic 2015 | 3 páginas | OSAP01 | ||
Cambio de datos del director Jason Edwin Sippel el 08 ene 2016 | 3 páginas | OSCH03 | ||
Nombramiento de Christopher Louis Berthe como director el 14 dic 2015 | 3 páginas | OSAP01 | ||
Cambio de datos del director Timothy James Osborne Throsby el 01 sept 2014 | 3 páginas | OSCH03 | ||
Cambio de datos del director Jason Sippel el 01 sept 2015 | 3 páginas | OSCH03 | ||
Nombramiento de Paul Francis Brannan como director el 15 dic 2015 | 3 páginas | OSAP01 | ||
Modificación de los documentos constitutivos el 05 ago 2010 | 18 páginas | OSCC01 | ||
Cambios para una sociedad extranjera - Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Usa | 4 páginas | OSCH02 | ||
Cese del nombramiento de Mary Frances Vance como secretario el 14 dic 2015 | 2 páginas | OSTM02 | ||
Cese del nombramiento de Yeng Yeng Maxwell como secretario el 14 dic 2015 | 2 páginas | OSTM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 16 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de John Horner como director el 17 abr 2015 | 2 páginas | OSTM01 | ||
Nombramiento de Jeffrey Lipman como secretario el 13 feb 2015 | 3 páginas | OSAP03 | ||
Cese del nombramiento de Carlos Hernandez como director el 03 oct 2014 | 2 páginas | OSTM01 | ||
Cese del nombramiento de Colleen Anne Meade como secretario el 01 dic 2008 | 2 páginas | OSTM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 16 páginas | AA | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 17 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Andrea Angelone como director | 2 páginas | OSTM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 16 páginas | AA | ||
Nombramiento de Yeng Yeng Maxwell como persona autorizada para aceptar notificaciones para el establecimiento en el Reino Unido BR001994 el 06 jul 2012. | 2 páginas | OSAP07 | ||
¿Quiénes son los directivos de J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC.?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPMAN, Jeffrey | Secretario | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 Uk | British | 195536750001 | ||||||
| BELBACHIR, Abdelfater | Director | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | Ney York United States Of America | French | 205119510001 | |||||
| BERTHE, Christopher Louis | Director | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | New York United States Of America | American | 204669420001 | |||||
| BRANNAN, Paul Francis | Director | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 United Kingdom | Connecticut United States Of America | British | 92879690002 | |||||
| SIPPEL, Jason Edwin | Director | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | United Kingdom | British | 149482060002 | |||||
| BERRY, James Clifford Pierce | Secretario | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | American | 79713580002 | ||||||
| LAWSON, Jane Elizabeth | Secretario | 2a Lee Terrace Blackheath SE3 9TZ London | British | 47291860001 | ||||||
| MAXWELL, Yeng Yeng | Secretario | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | British | 66736370004 | ||||||
| MEADE, Colleen Anne | Secretario | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | British | 116239730001 | ||||||
| SAMSON, Timothy Hugh | Secretario | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | American | 97409050002 | ||||||
| SZYPULA, Richard Michael | Secretario | 2 Hobart Street FOREIGN Bronxville Ny 10708 Usa | Usa | 30009470001 | ||||||
| VANCE, Mary Frances | Secretario | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | British | 96140800001 | ||||||
| ANGELONE, Andrea Giovanni | Director | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | Italian | 98441580003 | ||||||
| BRANDOW, Paul | Director | 135 East. 74th St.,Apt.5b New York Ny 10021 Usa | Usa | 92167650001 | ||||||
| BRETT, James | Director | 16 Birch Lane Greenwich Ct 06830 Usa | American | 93166600001 | ||||||
| CHRISTIAN JEAN LOUIS, Dalban | Director | 5 Courtfield Mews SW5 0NH London | French | 76710380002 | ||||||
| COLAS, Oliver | Director | 58 Chelsea Park Gardens SW3 London | French | 47291830001 | ||||||
| CORRIE, John Richard Duncan | Director | Sullingstead Hascombe Road GU8 4AE Godalming Surrey | England | British | 80720100001 | |||||
| DELUCA, John Charles | Director | London Wall EC2Y 5AJ London 125 | Usa | American | 149482670001 | |||||
| ENTHOVEN, Michael | Director | 60 Otter Rock Drive Greenwich Connecticut 06830 Usa | Dutch | 31709610001 | ||||||
| GRAY, Robert Blackburn | Director | 9 St Simons Avenue SW15 6DU London | England | British | 26727060001 | |||||
| GUBERT, Walter Alexander | Director | 14 Edwardes Square W8 6HE London | Italian | 28886800001 | ||||||
| HENDRICKS, Maureen Agnes | Director | 33 Lansdowne Road W11 2LQ London | American | 47292200001 | ||||||
| HERNANDEZ, Carlos | Director | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 | American | 93166670001 | ||||||
| HORNER, John | Director | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 England | United States | American | 170579190001 | |||||
| LONG, David Nicholas | Director | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | British | 98441570003 | ||||||
| LOWE, Claus | Director | 16 Marryat Road SW19 5BD Wimbledon London | German | 47292190002 | ||||||
| LYALL, Ian Robert | Director | 125 London Wall EC2Y 5AJ London | England | British | 181859690001 | |||||
| MAYER, JR, John Anton | Director | 7 Upland Drive Greenwich Connecticut 06831 Usa | American | 47291850001 | ||||||
| MEIER, Marcus | Director | 109 Bank Street New York New York 10014 Usa | Swiss | 47292180001 | ||||||
| MOSES, Menasey Marc | Director | Nw4 | British | 68184260001 | ||||||
| PATTERSON, Michael Ellmore | Director | 530 East 86th Street 10021 New York New York 10028 Usa | American | 47292170001 | ||||||
| PINILLA, Juan-Carlos | Director | 75e 75th Street New York Ny 10021 Usa | Spanish | 92629140001 | ||||||
| SAIER, George Arnaud | Director | 46 Holland Street W8 4LX London | French | 102990210001 | ||||||
| THROSBY, Timothy James Osborne | Director | Bank Street Canary Wharf E14 5JP London 25 England | England | Australian | 170579950001 |
¿Tiene J.P. MORGAN WHITEFRIARS INC. alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Securities pledge agreement | Creado el 23 dic 2003 Entregado el 09 ene 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The securities pledge agreement creates security over the 'pledged collateral'. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 09 ene 1992 Entregado el 14 ene 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All shares,stock and other securities of any description for the time being desinated by the stock exchange as talisman securities time to time registered in the name of or comprised in a transfer of any nominee company (see form 395 document m 30C for full details.). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed | Creado el 31 mar 1988 Entregado el 08 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción Fixed charge all sums from time to time deposited by the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security agreement | Creado el 31 mar 1988 Entregado el 08 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from the company morgan guaranty trust company of new york under or in respect of the "secured sums" (as defined in the terms of the charge | |
Breve descripción All rights,claims and interests of the company in and to the stocks/shares (please see form 395 for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0