NEVIS LEASING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Dirección
  • Cuentas
  • Sociedad extranjera
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEVIS LEASING LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaSociedad extranjera
    Número de empresa FC026796
    JurisdicciónReino Unido
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Dónde se encuentra NEVIS LEASING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    47 Esplanade
    St Helier
    JE1 0BD Jersey
    Channel Islands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEVIS LEASING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    NEVIS LEASING LIMITED es una empresa extranjera

    Requisitos contables de la sociedad extranjera
    Tipo de cuenta extranjeraNo se aplican los requisitos contables del país de origen
    Condiciones de publicación de las cuentasFecha de referencia contable asignada por Companies House
    Actividad comercialOwning And Leasing Vessels
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Es una entidad de crédito o financieraNo
    Regido porCompanies (Jersey) Law 1991 (As Amended)
    País de registro de origenCHANNEL ISLANDS
    Lugar de registroThe Companies Registry, Jersey
    Número de empresa93443

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEVIS LEASING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cierre del establecimiento en el Reino Unido BR008808 y de la empresa extranjera FC026796 el 30 jun 2017

    2 páginasOSDS01

    Cese del nombramiento de Colin Graham Dowsett como director el 16 nov 2016

    2 páginasOSTM01

    Cancelación total de la carga 1

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    3 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Richard Owen Williams como director el 19 sept 2016

    2 páginasOSTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    14 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    16 páginasAA

    Cese del nombramiento de Crills Secretaries Limited como secretario

    2 páginasOSTM02

    Cese del nombramiento de Simon Gledhill como director

    2 páginasOSTM01

    Cese del nombramiento de Paul Gittins como secretario

    2 páginasOSTM02

    Nombramiento de un secretario

    3 páginasOSAP03

    Nombramiento de un director

    3 páginasOSAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    17 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    18 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Cumming como director

    2 páginasOSTM01

    Nombramiento de un director

    3 páginasOSAP01

    Cese del nombramiento para un establecimiento del Reino Unido - Transaction OSTM03- BR008808 Person Authorised to Represent terminated 30/09/2011 lambertus hendrik veldhuizen

    2 páginasOSTM03

    Cese del nombramiento de Lambertus Veldhuizen como director

    2 páginasOSTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    18 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    20 páginasAA

    Cese del nombramiento de Aidan Smith como director

    2 páginasOSTM01

    Cese del nombramiento de Ian Atkinson como director

    2 páginasOSTM01

    Cese del nombramiento de David Shindler como director

    2 páginasOSTM01

    Nombramiento de un director

    3 páginasOSAP01

    Nombramiento de un director

    3 páginasOSAP01

    ¿Quiénes son los directivos de NEVIS LEASING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JOHNSON, Michelle Antoinete Angela
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East Tower House
    Cheshire
    Secretario
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East Tower House
    Cheshire
    British181597670001
    FOX, Gerard Ashley
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish179100520001
    GITTINS, Paul
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Charterhall House
    Cheshire
    Secretario
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Charterhall House
    Cheshire
    British45660860003
    CRILLS SECRETARIES LIMITED
    44 Esplanade
    St. Helier
    Je4 8pn
    Jersey
    Secretario corporativo
    44 Esplanade
    St. Helier
    Je4 8pn
    Jersey
    112997890001
    ATKINSON, Ian Muir
    Avalon Gardens
    Linlithgow Bridge
    EH49 7PL Linlithgow
    84
    West Lothian
    Scotland
    Director
    Avalon Gardens
    Linlithgow Bridge
    EH49 7PL Linlithgow
    84
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish133052170001
    CARLSSON, Svante Wilhelm
    Terragatan 5
    FOREIGN Se 411 83 Gothenburg
    Sweden
    Director
    Terragatan 5
    FOREIGN Se 411 83 Gothenburg
    Sweden
    SwedenSwedish126524710001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    Director
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United KingdomBritish46297770002
    DOWSETT, Colin Graham
    Aldershot Road
    GU51 3NN Fleet
    26a
    Hampshire
    Director
    Aldershot Road
    GU51 3NN Fleet
    26a
    Hampshire
    EnglandBritish152332230001
    DRURY, Charles Esmond Hill
    Ladywell House
    HR2 0RE Turnastone
    Herefordshire
    Director
    Ladywell House
    HR2 0RE Turnastone
    Herefordshire
    WalesBritish59871850002
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United KingdomBritish152766650001
    PERCY, Michael Hugh
    32 Hazlewell Road
    SW15 6LH London
    Director
    32 Hazlewell Road
    SW15 6LH London
    EnglandBritish20962040001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Director
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    POUTEAUX, Andrew John
    Thorsby 26
    Crownpits Lane
    GU7 1PB Godalming
    Surrey
    Director
    Thorsby 26
    Crownpits Lane
    GU7 1PB Godalming
    Surrey
    British62522880002
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Director
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    British92235400001
    SMITH, Aidan John
    Terrilands
    HA5 3AJ Pinner
    4
    Middlesex
    Director
    Terrilands
    HA5 3AJ Pinner
    4
    Middlesex
    EnglandBritish131026160001
    VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United KingdomDutch152683120001
    WALSH, Kenton
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish125918020001
    WILLIAMS, Richard Owen
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    6th Floor 33
    England
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    6th Floor 33
    England
    EnglandBritish164554190001

    ¿Tiene NEVIS LEASING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 04 dic 2007
    Entregado el 20 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    64/64 shares in the ship (being M.V. stena trader) and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stena Tulip Limited
    Transacciones
    • 20 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 04 dic 2007
    Entregado el 20 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    64/64 shares in the ship (being M.V. stena traveller) and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stena Anglia Limited
    Transacciones
    • 20 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Lessor proceeds account relating to "stena traveller"
    Creado el 04 dic 2007
    Entregado el 20 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The lessor proceeds account moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stena Anglia Limited
    Transacciones
    • 20 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of covenant re "stena traveller"
    Creado el 04 dic 2007
    Entregado el 20 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The ship and proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stena Anglia Limited
    Transacciones
    • 20 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Lessor proceeds account charge relating to "stena trader"
    Creado el 04 dic 2007
    Entregado el 20 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The lessor proceeds account moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stena Tulip Limited
    Transacciones
    • 20 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of covenant re M.V. "stena trader"
    Creado el 04 dic 2007
    Entregado el 20 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly k/a stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The ship "stena trader" and all proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stena Tulip Limited
    Transacciones
    • 20 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment of insurances and requisition compensation
    Creado el 09 ago 2006
    Entregado el 21 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from stena tulip limited to the banks or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights in and to the insurances of the ship stena trader, requisition compensation,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transacciones
    • 21 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of covenants
    Creado el 09 ago 2006
    Entregado el 21 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from stena tulip limited to the banks or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights in the ship stena trader official number 737906,. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transacciones
    • 21 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First priority mortgage
    Creado el 07 ago 2006
    Entregado el 21 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from stena tulip limited to the banks or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Sixty four sixty fourth shares in the ship stena trader official number 737906,. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transacciones
    • 21 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Novation of receivables purchase agreement
    Creado el 18 may 2006
    Entregado el 01 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the company's rights, title and interest in and to its right under or pursuant to a loan agreement dated 15TH may 2006 relation to the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stena (Switzerland) Ag (the Receivables Purchaser)
    Transacciones
    • 01 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Novation of receivables purchase agreement
    Creado el 18 may 2006
    Entregado el 01 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the company's rights, title and interest in and to its right under or pursuant to a loan agreement dated 15TH may 2006 relation to the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stena (Switzerland) Ag (the Receivables Purchaser)
    Transacciones
    • 01 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 2016Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0