CARE HOMES NO. 1 LIMITED

CARE HOMES NO. 1 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Dirección
  • Cuentas
  • Sociedad extranjera
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARE HOMES NO. 1 LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaSociedad extranjera
    Número de empresa FC027201
    Número de registro externo71496
    JurisdicciónReino Unido
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Dónde se encuentra CARE HOMES NO. 1 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Walkers Corporate Limited Cayman Corporate Centre
    27 Hospital Road
    George Town
    Grand Cayman Ky1-9008
    Cayman Islands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARE HOMES NO. 1 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2020

    CARE HOMES NO. 1 LIMITED es una empresa extranjera

    Requisitos contables de la sociedad extranjera
    Tipo de cuenta extranjeraNo se aplican los requisitos contables del país de origen
    Condiciones de publicación de las cuentasFecha de referencia contable asignada por Companies House
    Actividad comercialThe Company Holds Long Leasehold Interests In Properties
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    Es una entidad de crédito o financieraNo
    Regido porThe Companies Law (2004 Revision) Of The Cayman Islands
    País de registro de origenCAYMAN ISLANDS
    Lugar de registroCompany Registry, Cayman Islands
    Número de empresa71496

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARE HOMES NO. 1 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cierre del establecimiento en el Reino Unido BR009123 y de la empresa extranjera FC027201 el 20 dic 2021

    2 páginasOSDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020

    21 páginasAA

    Nombramiento de Mr James Walter Tugendhat como director el 14 sept 2020

    3 páginasOSAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de James Justin Hutchens como director el 05 feb 2020

    2 páginasOSTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2018

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr James Justin Hutchens como director el 26 sept 2017

    4 páginasOSAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    15 mar 2018Clarification THIS DOCUMENT IS A SECOND FILING OF THE FORM OSAP01 REGISTERED ON 23/10/2017.

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr James Justin Hutchens como director el 06 oct 2017

    4 páginasOSAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    15 mar 2018Clarification A SECOND FILED OSAP01 WAS REGISTERED ON 15/03/2018.

    Cese del nombramiento de Chaitanya Bhupendra Patel como director el 06 oct 2017

    2 páginasOSTM01

    Cambios para una sociedad extranjera - M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309Gt, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman Islands

    4 páginasOSCH02

    Cambios para un establecimiento del Reino Unido - BR009123 Address Change Liberty house 222 regent street, london, W1B 5TR,19 sept 2017

    3 páginasOSCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016

    17 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2015

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jeremy Michael Jorgen Malherbe Jensen como director el 06 feb 2015

    2 páginasOSTM01

    Cese del nombramiento de Paul Hugh Thompson como director el 06 feb 2015

    2 páginasOSTM01

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director el 06 feb 2015

    3 páginasOSAP01

    Nombramiento de Chaitanya Bhupendra Patel como director el 06 feb 2015

    3 páginasOSAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2014

    15 páginasAA

    Cancelación total de la carga 4

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    3 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2013

    16 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2012

    15 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    15 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    15 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CARE HOMES NO. 1 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MAPLE SECRETARIES LIMITED
    PO BOX 1093gt
    Queensgate House
    South Church Street
    Grand Cayman
    Caymanislands
    Secretario corporativo
    PO BOX 1093gt
    Queensgate House
    South Church Street
    Grand Cayman
    Caymanislands
    117624480001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    Director
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish147997950001
    TUGENDHAT, James Walter
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    Director
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish218306870001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Director
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    GRANT, Michael John
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    Director
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    EnglandBritish141668610001
    HENDERSON-CLELAND, Hugh
    91 Carlton Avenue
    Dulwich
    SE21 7DF London
    Director
    91 Carlton Avenue
    Dulwich
    SE21 7DF London
    British117624980001
    HUTCHENS, James Justin
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    Director
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomAmerican238334580002
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    Chiswick Quay
    W4 3UR London
    25
    Director
    Chiswick Quay
    W4 3UR London
    25
    EnglandBritish108268030003
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Director
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Director
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001
    NICHOLSON, Daniel Christopher
    181 Seagrave Road
    SW6 1ST London
    Director
    181 Seagrave Road
    SW6 1ST London
    EnglandBritish77890230001
    PATEL, Chaitanya Bhupendra
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    Director
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish63915280004
    TAYLOR, Paul Vincent
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    Director
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    United KingdomBritish71978710001
    THOMPSON, Paul Hugh
    St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    15b
    Kent
    Director
    St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    15b
    Kent
    EnglandBritish100977220001

    ¿Tiene CARE HOMES NO. 1 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A deed of mortgage/charge
    Creado el 15 ene 2007
    Entregado el 01 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All f/h and l/h unregistered property (if any) including without limitation all that property more particularly set out in part ii of schedule 1 to the deed of mortgage and all property registered at land registry of northern ireland including all that property more particularly set out in part iii of schedule 1 to the deed of mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse
    Transacciones
    • 01 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A security deed
    Creado el 15 ene 2007
    Entregado el 30 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse, London Branch
    Transacciones
    • 30 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of mortgage/charge
    Creado el 12 dic 2006
    Entregado el 21 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rockfield nursing home, windmill road, newry, county down t/n 244L and DN33033050. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite debenture
    Creado el 12 dic 2006
    Entregado el 21 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0