CARE HOMES NO. 1 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARE HOMES NO. 1 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Convertida/Cerrada |
| Forma jurídica | Sociedad extranjera |
| Número de empresa | FC027201 |
| Número de registro externo | 71496 |
| Jurisdicción | Reino Unido |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Dónde se encuentra CARE HOMES NO. 1 LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Walkers Corporate Limited Cayman Corporate Centre 27 Hospital Road George Town Grand Cayman Ky1-9008 Cayman Islands |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARE HOMES NO. 1 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2020 |
CARE HOMES NO. 1 LIMITED es una empresa extranjera
| Requisitos contables de la sociedad extranjera | |
|---|---|
| Tipo de cuenta extranjera | No se aplican los requisitos contables del país de origen |
| Condiciones de publicación de las cuentas | Fecha de referencia contable asignada por Companies House |
| Actividad comercial | The Company Holds Long Leasehold Interests In Properties |
| Forma jurídica | Company Limited By Shares |
| Es una entidad de crédito o financiera | No |
| Regido por | The Companies Law (2004 Revision) Of The Cayman Islands |
| País de registro de origen | CAYMAN ISLANDS |
| Lugar de registro | Company Registry, Cayman Islands |
| Número de empresa | 71496 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARE HOMES NO. 1 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cierre del establecimiento en el Reino Unido BR009123 y de la empresa extranjera FC027201 el 20 dic 2021 | 2 páginas | OSDS01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020 | 21 páginas | AA | ||||||
Nombramiento de Mr James Walter Tugendhat como director el 14 sept 2020 | 3 páginas | OSAP01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019 | 17 páginas | AA | ||||||
Cese del nombramiento de James Justin Hutchens como director el 05 feb 2020 | 2 páginas | OSTM01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2018 | 18 páginas | AA | ||||||
Nombramiento de Mr James Justin Hutchens como director el 26 sept 2017 | 4 páginas | OSAP01 | ||||||
| ||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017 | 18 páginas | AA | ||||||
Nombramiento de Mr James Justin Hutchens como director el 06 oct 2017 | 4 páginas | OSAP01 | ||||||
| ||||||||
Cese del nombramiento de Chaitanya Bhupendra Patel como director el 06 oct 2017 | 2 páginas | OSTM01 | ||||||
Cambios para una sociedad extranjera - M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309Gt, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman Islands | 4 páginas | OSCH02 | ||||||
Cambios para un establecimiento del Reino Unido - BR009123 Address Change Liberty house 222 regent street, london, W1B 5TR,19 sept 2017 | 3 páginas | OSCH01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 17 páginas | AA | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2015 | 14 páginas | AA | ||||||
Cese del nombramiento de Jeremy Michael Jorgen Malherbe Jensen como director el 06 feb 2015 | 2 páginas | OSTM01 | ||||||
Cese del nombramiento de Paul Hugh Thompson como director el 06 feb 2015 | 2 páginas | OSTM01 | ||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director el 06 feb 2015 | 3 páginas | OSAP01 | ||||||
Nombramiento de Chaitanya Bhupendra Patel como director el 06 feb 2015 | 3 páginas | OSAP01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2014 | 15 páginas | AA | ||||||
Cancelación total de la carga 4 | 3 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 3 | 3 páginas | MR04 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2013 | 16 páginas | AA | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2012 | 15 páginas | AA | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011 | 15 páginas | AA | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010 | 15 páginas | AA | ||||||
¿Quiénes son los directivos de CARE HOMES NO. 1 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPLE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | PO BOX 1093gt Queensgate House South Church Street Grand Cayman Caymanislands | 117624480001 | |||||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Director | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham United Kingdom | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| TUGENDHAT, James Walter | Director | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham United Kingdom | United Kingdom | British | 218306870001 | |||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Director | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Director | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||
| GRANT, Michael John | Director | Edwill Way BR3 6RY Beckenham 73 Kent | England | British | 141668610001 | |||||
| HENDERSON-CLELAND, Hugh | Director | 91 Carlton Avenue Dulwich SE21 7DF London | British | 117624980001 | ||||||
| HUTCHENS, James Justin | Director | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham United Kingdom | United Kingdom | American | 238334580002 | |||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Director | Chiswick Quay W4 3UR London 25 | England | British | 108268030003 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Director | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | England | British | 110640170001 | |||||
| MOY, Neal St John | Director | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | 98781970001 | ||||||
| NICHOLSON, Daniel Christopher | Director | 181 Seagrave Road SW6 1ST London | England | British | 77890230001 | |||||
| PATEL, Chaitanya Bhupendra | Director | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham United Kingdom | United Kingdom | British | 63915280004 | |||||
| TAYLOR, Paul Vincent | Director | Destiny 49 The Highway SM2 5QS South Sutton Surrey | United Kingdom | British | 71978710001 | |||||
| THOMPSON, Paul Hugh | Director | St Johns Road TN13 3LR Sevenoaks 15b Kent | England | British | 100977220001 |
¿Tiene CARE HOMES NO. 1 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of mortgage/charge | Creado el 15 ene 2007 Entregado el 01 feb 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All f/h and l/h unregistered property (if any) including without limitation all that property more particularly set out in part ii of schedule 1 to the deed of mortgage and all property registered at land registry of northern ireland including all that property more particularly set out in part iii of schedule 1 to the deed of mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A security deed | Creado el 15 ene 2007 Entregado el 30 ene 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of mortgage/charge | Creado el 12 dic 2006 Entregado el 21 dic 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Rockfield nursing home, windmill road, newry, county down t/n 244L and DN33033050. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite debenture | Creado el 12 dic 2006 Entregado el 21 dic 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0