WELCOME BREAK CAYMAN LIMITED

WELCOME BREAK CAYMAN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Dirección
  • Cuentas
  • Sociedad extranjera
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWELCOME BREAK CAYMAN LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaSociedad extranjera
    Número de empresa FC027450
    JurisdicciónReino Unido
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Dónde se encuentra WELCOME BREAK CAYMAN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Walker House, 87 Mary Street,
    George Town,
    Grand Cayman,
    Ky1-9002, Cayman Islands
    Cayman Islands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WELCOME BREAK CAYMAN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta26 ene 2016

    WELCOME BREAK CAYMAN LIMITED es una empresa extranjera

    Requisitos contables de la sociedad extranjera
    Tipo de cuenta extranjeraNo se aplican los requisitos contables del país de origen
    Condiciones de publicación de las cuentasFecha de referencia contable asignada por Companies House
    Actividad comercialUnrestricted Unless Prohibited By Section 7 Of The Companies Law
    Forma jurídicaPrivate Limited Company By Shares
    Es una entidad de crédito o financieraNo
    Regido porCompanies Law Of The Cayman Islands
    País de registro de origenCAYMAN ISLANDS
    Lugar de registroRegistrar Of Companies In And For The Cayman Islands, Located In
    Número de empresaN/A

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WELCOME BREAK CAYMAN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cierre del establecimiento en el Reino Unido BR009316 y de la empresa extranjera FC027450 el 03 oct 2017

    2 páginasOSDS01

    Cese del nombramiento para un establecimiento del Reino Unido - Transaction OSTM03- BR009316 Person Authorised to Represent terminated 23/05/2017 arthur tadeusz kawonczyk

    3 páginasOSTM03

    Cese del nombramiento para un establecimiento del Reino Unido - Transaction OSTM03- BR009316 Person Authorised to Represent terminated 23/05/2017 anne grandin

    3 páginasOSTM03

    Cese del nombramiento de Anne Grandin como director el 23 may 2017

    2 páginasOSTM01

    Cese del nombramiento de Artur Tadeusz Kawonczyk como director el 23 may 2017

    2 páginasOSTM01

    Nombramiento de Mr Peter Bartholomew O'flaherty como director el 11 nov 2016

    4 páginasOSAP01

    Nombramiento de Peter Bartholomew O'flaherty como persona autorizada para representar al establecimiento en el Reino Unido BR009316 el 11 nov 2016.

    4 páginasOSAP05

    Cese del nombramiento para un establecimiento del Reino Unido - Transaction OSTM03- BR009316 Person Authorised to Represent terminated 11/11/2016 michael derek canham

    3 páginasOSTM03

    Cese del nombramiento de Michael Derek Canham como director el 11 nov 2016

    2 páginasOSTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 26 ene 2016

    50 páginasAA

    Cambio de datos para Lisa Marie Parsons de 2 Vantage Court Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire, Mk16 9Ez como persona autorizada para representar al establecimiento del Reino Unido BR009316 el 19 ago 2016

    3 páginasOSCH07

    Cambio de datos del director Mrs Lisa Marie Parsons el 19 ago 2016

    3 páginasOSCH03

    Cambio de datos del director Mrs Lisa Marie Parsons el 27 nov 2015

    3 páginasOSCH03

    Cambio de datos para Lisa Marie Parsons de 2 Vantage Court Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire, Mk16 9Ez, England como persona autorizada para representar al establecimiento del Reino Unido BR009316 el 27 nov 2015

    3 páginasOSCH07

    Cambio de datos para Darren Stephen Kyte de 2 Vantage Court Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire, Mk16 9Ez como persona autorizada para representar al establecimiento del Reino Unido BR009316 el 24 ago 2015

    3 páginasOSCH07

    Cambio de datos del director Mr Darren Stephen Kyte el 24 ago 2015

    3 páginasOSCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 ene 2015

    10 páginasAA

    Cese del nombramiento para un establecimiento del Reino Unido - Transaction OSTM03- BR009316 Person Authorised to Represent terminated 11/12/2014 george gavin mullett

    3 páginasOSTM03

    Cese del nombramiento de George Gavin Mullett como director el 11 dic 2014

    2 páginasOSTM01

    Nombramiento de Anne Grandin como persona autorizada para representar al establecimiento en el Reino Unido BR009316 el 11 dic 2014.

    4 páginasOSAP05

    Nombramiento de Anne Grandin como director el 11 dic 2014

    4 páginasOSAP01

    Nombramiento de Lisa Marie Parsons como persona autorizada para representar al establecimiento en el Reino Unido BR009316 el 21 oct 2014.

    4 páginasOSAP05

    Nombramiento de Mrs Lisa Marie Parsons como director el 21 oct 2014

    4 páginasOSAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 ene 2014

    10 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 ene 2013

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de WELCOME BREAK CAYMAN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KYTE, Darren Stephen
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    Director
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish77473690006
    MCKIE, Roderick Wallace
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    Director
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    EnglandBritish80931680025
    O'FLAHERTY, Peter Bartholomew
    Vantage Court
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2
    Bucks
    England
    Director
    Vantage Court
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2
    Bucks
    England
    United KingdomIrish129573590001
    PARSONS, Lisa Marie
    Vantage Court
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2
    Bucks
    England
    Director
    Vantage Court
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2
    Bucks
    England
    EnglandBritish173619300003
    WRIGHT, Nicholas David
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    Director
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92442510002
    WALKER, Ruth Alison
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    Secretario
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    British110799670001
    BARR, Paul Johnstone
    Tickford Street
    Newport Pagnell
    MK16 9EZ Milton Keynes
    2 Vantage Court
    Director
    Tickford Street
    Newport Pagnell
    MK16 9EZ Milton Keynes
    2 Vantage Court
    United KingdomBritish134764120001
    CANHAM, Michael Derek
    Tickford Street
    Newport Pagnell
    MK16 9EZ Milton Keynes
    2 Vantage Court
    Director
    Tickford Street
    Newport Pagnell
    MK16 9EZ Milton Keynes
    2 Vantage Court
    United KingdomBritish77473720002
    DICKIE, Brian Norman
    26 Holland Street
    W8 4LT London
    Director
    26 Holland Street
    W8 4LT London
    British80396010002
    DOWLING, Christopher Bruce
    110 Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HU London
    Director
    110 Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HU London
    United KingdomAustralian28868820003
    FINEGAN, Andrea
    Belmont Grove
    SE13 5DU London
    26 Belmont Hall Court
    Director
    Belmont Grove
    SE13 5DU London
    26 Belmont Hall Court
    United KingdomGerman65514200010
    GRANDIN, Anne Andree Marie
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Bucks
    England
    Director
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Bucks
    England
    United KingdomFrench193535920001
    KAWONCZYK, Artur Tadeusz
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135293650001
    LOVE, David Arthur
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    Director
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    United KingdomNew Zealander141161860001
    MACARTNEY, Elizabeth Anne
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    Director
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    UkBritish90329160001
    MAHONEY, James
    Flat B
    192 Westbourne Park Road
    W11 1BT London
    Director
    Flat B
    192 Westbourne Park Road
    W11 1BT London
    New Zealand117745610001
    MULLETT, George Gavin
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandAustralian173186890003
    O'FLAHERTY, Peter Bartholomew
    Eastfield Road
    CM14 4HB Brentwood
    15
    Essex
    Director
    Eastfield Road
    CM14 4HB Brentwood
    15
    Essex
    United KingdomIrish129573590001
    PETERS, Phillip William
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Tickford Street
    MK16 9EZ Newport Pagnell
    2 Vantage Court
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish196913220002

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0