VICO PROPERTY GROUP LIMITED

VICO PROPERTY GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVICO PROPERTY GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa NI007925
    JurisdicciónIrlanda del Norte
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VICO PROPERTY GROUP LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra VICO PROPERTY GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o T MCCOURT & CO
    19 Bachelors Walk
    BT28 1XJ Lisburn
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VICO PROPERTY GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VICO PROPERTY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY28 may 201528 may 2015
    VICO PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY22 ene 199222 ene 1992
    VICO DEVELOPMENT LIMITED08 jun 197008 jun 1970

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VICO PROPERTY GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VICO PROPERTY GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Notificación de la reunión final de acreedores

    1 páginas4.44(NI)

    Nombramiento de un liquidador (compulsorio)

    1 páginas4.32(NI)

    Orden del tribunal para liquidar

    1 páginasCOCOMP

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cancelación total de la carga 23

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 21

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga NI0079250026

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 24

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 25

    1 páginasMR04

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 06 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 dic 2015

    Estado de capital el 23 dic 2015

    • Capital: GBP 2,539.718
    SH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 01 sept 2015

    • Capital: GBP 2,363.4977
    3 páginasSH01

    Cese del nombramiento de Christopher Mark Carvill como director el 06 ago 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 09 jul 2015

    • Capital: GBP 2,363.4977
    4 páginasSH06

    Subdivisión, reconversión de acciones el 09 jul 2015

    5 páginasSH02

    Resoluciones

    Resolutions
    10 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12
    capital

    Resoluciones

    Subdivision of shares; terms of contract approved 27/07/2015
    RES13

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 jul 2015

    • Capital: GBP 808,051.1036
    4 páginasSH01

    Compra de acciones propias.

    3 páginasSH03

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2014

    34 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre y re-registro de Compañía Pública Limitada a Privada

    1 páginasCERT11

    Re-registro del Memorándum y Estatutos

    18 páginasMAR

    ¿Quiénes son los directivos de VICO PROPERTY GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRYSON, Christopher Patrick
    c/o T Mccourt & Co
    Bachelors Walk
    BT28 1XJ Lisburn
    19
    Northern Ireland
    Secretario
    c/o T Mccourt & Co
    Bachelors Walk
    BT28 1XJ Lisburn
    19
    Northern Ireland
    179173380001
    CARVILL, Charles Joseph
    Well Road
    Warrenpoint
    BT34 3RS Newry
    29
    County Down
    Director
    Well Road
    Warrenpoint
    BT34 3RS Newry
    29
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish979740003
    CARVILL, Micheal F.
    6 Rostrevor Terrace
    Orwell Road
    DUBLIN 6 Rathgal
    Director
    6 Rostrevor Terrace
    Orwell Road
    DUBLIN 6 Rathgal
    IrelandIrish143134890001
    CARVILL, Thomas
    76 Killowen Old Road
    Killowen
    BT34 3AE Rostrevor
    Co Down
    Secretario
    76 Killowen Old Road
    Killowen
    BT34 3AE Rostrevor
    Co Down
    Irish201100001
    BOUCHE, Jean Michel
    Baycove Lodge
    Sandycove East Lane
    Sandycove
    Co Dublin
    Director
    Baycove Lodge
    Sandycove East Lane
    Sandycove
    Co Dublin
    French80014410001
    CARVILL, Christopher Mark
    43 Corbett Road
    Katesbridge
    BT32 3SH Banbridge
    Co Down
    Director
    43 Corbett Road
    Katesbridge
    BT32 3SH Banbridge
    Co Down
    Northern IrelandNorthern Irish81636250005
    CARVILL, Thomas
    Killowen Old Road
    Rostrevor
    BT34 3AE Newry
    76
    County Down
    Director
    Killowen Old Road
    Rostrevor
    BT34 3AE Newry
    76
    County Down
    Northern IrelandIrish201100001
    MACCALLUM, Alasdair Norman
    Inverossie
    Rossie Brae
    DD10 9TJ Montrose
    Scotland
    Director
    Inverossie
    Rossie Brae
    DD10 9TJ Montrose
    Scotland
    ScotlandBritish465170001
    SNEDDON, Richard
    28 St.Vincents Street South
    Stratford
    Ontario
    Canada
    Director
    28 St.Vincents Street South
    Stratford
    Ontario
    Canada
    CanadaBritish143134870001
    TAYLOR, Colin Michael
    Kirklea
    Gyffe Road
    PA13 4BA Kilmacolm
    Inverclyde
    Director
    Kirklea
    Gyffe Road
    PA13 4BA Kilmacolm
    Inverclyde
    ScotlandBritish107860600001

    ¿Tiene VICO PROPERTY GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 20 dic 2013
    Entregado el 31 dic 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    All and whole the subjects known as land to the rear of 19-31 high street, cowdenbeath being the subjects registered in the land register of scotland under title number FFE98839.
    Personas con derecho
    • Awd Trustees Limited (As Trustee of the Vico Retirement Fund)
    • Colin Taylor (As Trustee of the Vico Retirement Fund)
    • Michael Carvill (As Trustee of the Vico Retirement Fund)
    Transacciones
    • 31 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    • 04 jul 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security executed on 12 november 2012
    Creado el 20 dic 2012
    Entregado el 07 ene 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All and whole the subjects known as land to the rear of 19-31 high street, cowdenbeath being the subjects registered in the land register of scotland.
    Personas con derecho
    • Awd Trustees Limited
    • Colin Taylor
    • Michael Carvill
    Transacciones
    • 07 ene 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 04 jul 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 21 jul 2011
    Entregado el 30 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    That area or piece of land at high street, cowdenbeath, more particularly described as follows: all and whole (in the first place) all and whole that piece of ground extending to 2 acres and 9 one-thousandth part of an acre imperial measure or thereby, situated in the burgh of cowdenbeath and county of fife...see image for full details.
    Personas con derecho
    • Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer in Scotland
    Transacciones
    • 30 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 04 jul 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage or charge
    Creado el 25 may 2007
    Entregado el 01 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies charge. The premises comprised in folios DN92890 and DN6608, both county down.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 01 jun 2007Registro de una carga (402 NI)
    • 07 jul 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 18 abr 2005
    Entregado el 25 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies standard security.. Subject on the east of highfield drive, ayr, KA8 0LL registered under title number ayr 53852.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 25 abr 2005Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 11 jun 2004
    Entregado el 16 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies standard security subjects lying to the north west of auchenkilns roundabout, cumbernauld glasgow, title no dmb 72990.
    Personas con derecho
    • Glasgow
    • Governor & Co. Boi
    Transacciones
    • 16 jun 2004Registro de una carga (402 NI)
    • 07 jul 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage or charge
    Creado el 13 abr 2004
    Entregado el 19 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    Standard security all sums all and whole the subjects lying to the north west of auchenkilns roundabout, cumbernauld, glasgow which subjects are registered in the land register of scotland under title deed number dmb 72990 together with the rights contained in the deed of conditions in entry 1 of the burdens section of the said land certificate.
    Personas con derecho
    • Governor and Co
    • 19 St Vincents Place
    Transacciones
    • 19 abr 2004Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 27 jun 2001
    Entregado el 16 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    Standard security - all monies 30-34 and 38-54 king street, kilmarnock (otherwise known as phase 2, kilmarnock town centre), registered in the land registered of scotland under title number AYR35164 under exception of all and whole those subjects comprising 18-28 king street.......see doc no. 176 for further details.
    Personas con derecho
    • Northern Bank LTD
    Transacciones
    • 16 jul 2001Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 15 mar 1996
    Entregado el 05 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Standard security the heritable property comprising nos 129,133 and 135 george street, aberdeen being the subjects described in dispos- ition by carrycroft limited in favour of vico properties public limited company dated 12TH and recorded grs (aberdeen) 15TH march, 1996. property insurance proceeds: all rights benefits and claims (whether existing now or arising at any time in the future under the policy or policies of insur- ance for or covering the property or any interest in the property effected from time to time in accordance with the provisions of the deed of conditions.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 abr 1996Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 15 mar 1996
    Entregado el 26 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Standard security those subjects comprising the ground and basement shop units known as and forming 129,133 and 135 george street, aberdeen.
    Personas con derecho
    • Carrycroft Limited
    Transacciones
    • 26 mar 1996Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 06 feb 1996
    Entregado el 16 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Standard security see doc 138 for details.
    Personas con derecho
    • Northern Bank LTD
    Transacciones
    • 16 feb 1996Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 01 feb 1996
    Entregado el 16 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Standard security 198 and 200 bath street, glasgow being the subjects registered in th land register under title number gla 117523.
    Personas con derecho
    • Northern Bank LTD
    Transacciones
    • 16 feb 1996Registro de una carga (402 NI)
    • 06 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage or charge
    Creado el 09 ago 1995
    Entregado el 10 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Legal charge 1. all that freehold land situate on east side of shrewsbury avenue, peter- borough, cambridgeshire as same is registered at hm land registry with freehold title absolute under title number cb 123262 together with buildings erections fixtures and fittings (save for any tenant's fittings) and fixed plant and machinery for time being there on and all improvements and additions thereto. 2. by way of floating charge all unfixed.
    Personas con derecho
    • Nig Trading Limited
    Transacciones
    • 10 ago 1995Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 08 may 1995
    Entregado el 22 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Standard security all and whole the subjects situated on the north west of kyle st. Port dundas glasgow being the whole subjects regis- tered in the land register of scotland under title no. Gla 51795; together with (1) the whole buildings and erections (if any) thereon (2) the whole parts, privileges and pertinents effeiring thereto, (3) the whole fittings and fixtures therein and thereon and (4) the company's whole right title and interest present and future in and to the same. Plant machinery, materials goods, furniture and equipment now or from time to time upon the mortgaged premises.
    Personas con derecho
    • Lombard & Ulster
    Transacciones
    • 22 may 1995Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 06 dic 1994
    Entregado el 19 dic 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Standard security 254/254A union st. & 39 union row aberdeen as relative to deposition in favour of claud hamilton (aberdeen) LTD recorded 22/5/1920. 2 bridge st. & 1 bruce st. Dunfermline as relative to desposition in favour william low & co LTD recorded 11/12/1951 30 royal terrace edinburgh as described in notarial instrument in favour of miss janet mackinlay & others as trustees recorded 31/7/1866 and 18 royal terrace mews, edinburgh as described in disposition in favour of annie evelyn rose, recorded 20.5. 1926. 4 & 5 golden square aberdeen as described in disposition in favour of kirkwood house (investments) LTD recorded 10.8.1978.
    Transacciones
    • 19 dic 1994Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 19 mar 1992
    Entregado el 19 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Charge the lands and premises comprised in folio an 4004L county antrim.
    Personas con derecho
    • Bank of Ireland
    Transacciones
    • 19 mar 1992Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 21 feb 1989
    Entregado el 24 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Mortgage the lands comprised in folio nos AN4004L and AN5100L both county antrim and all machinery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Personas con derecho
    • Northern Bank LTD
    Transacciones
    • 24 feb 1989Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 12 may 1988
    Entregado el 17 may 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Mortgage all that part of the lands comprised in folio 26407 county antrim held under flease dated 22/4/88. all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Personas con derecho
    • Northern Bank LTD
    • Northern Bank LTD
    Transacciones
    • 17 may 1988Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 15 feb 1988
    Entregado el 02 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Mortgage the companys property being part of the lands comprised in folio nos 26641 and county antrim and also all machinery utensils chattels and things now or at any time fhereafter upon all of the aforesaid premises.
    Personas con derecho
    • Northern Bank Devel-
    Transacciones
    • 02 mar 1988Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 10 mar 1986
    Entregado el 12 mar 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Mortgage the companys premises at prospect mill flax street and ardilea street in the city of belfast held under a conveyance of 23/12/85 blackstaff properties LTD to vico developments limited.
    Personas con derecho
    • Lombard & Ulster
    Transacciones
    • 12 mar 1986Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 03 dic 1985
    Entregado el 11 dic 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Mortgage lands comprised in folio 25332 co antrim together withpart of the lands com- prised in folio 24791 co antrim and part of the lands comprised in folio 26641 co antrim held under lease dated 15/4/85 and also all machinery utensils chattels and things now or at any time herein- after upon all of the aforesaid premises.
    Personas con derecho
    • Northern Bank Devel-
    Transacciones
    • 11 dic 1985Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 14 ago 1985
    Entregado el 21 ago 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Mortgage premises situate in the townlands of kilmakee and derryaghy and county of antrim being part ofthe lands comprised in folio no 26641 county antrim together with machinery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Personas con derecho
    • Northern Bank Devel-
    Transacciones
    • 21 ago 1985Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 16 abr 1985
    Entregado el 17 abr 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Mortgage the companys leasehold land being part of the lands comprised in folio nos. 25332 and 24971 county antrim situate in the townland of derriaghy and county of antrim, and also all machinery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Personas con derecho
    • Northern Bank Devel-
    Transacciones
    • 17 abr 1985Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 08 feb 1984
    Entregado el 08 feb 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Mortgage the companys property situate at 33 ferryquay street and 1 and 2 artillery street londonderry and also all mach- inery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Personas con derecho
    • Northern Bank Devel-
    Transacciones
    • 08 feb 1984Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 26 feb 1981
    Entregado el 18 mar 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    150000
    Breve descripción
    Mortgage "all that part of the lands of lisnagar- vey situate in the barony of upper massereene and county of antrim contain- ing twenty two and one quarter perches statute measure or thereabouts bounded on the north by town commissioners bye wash covered on the south by bow street on the east by samuel j nelson's pre- mises and on the west by william norwood representative premises as said pre- mises are now in the occupation of the purchaser or his undertenants and held by the purchaser under lease dated 16/4/1741 from frances baron conway to james greer for lives renewable forever" which said premises are situate at and knwon as 24 bow street, lisburn in the county of antrim.
    Personas con derecho
    • Charles Street
    Transacciones
    • 18 mar 1981Registro de una carga (402 NI)

    ¿Tiene VICO PROPERTY GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 jul 2017Inicio de la liquidación
    16 sept 2019Conclusión de la liquidación
    19 dic 2019Fecha prevista de disolución
    11 jul 2017Fecha de la petición
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or Belfast
    Fermanagh House Ormeau Avenue
    BT2 8NJ Belfast
    County Antrim
    Profesional
    Fermanagh House Ormeau Avenue
    BT2 8NJ Belfast
    County Antrim
    Ken Pattullo
    Scottish Provident Building, 7 Donegall Square West
    BT1 6JH Belfast
    Profesional
    Scottish Provident Building, 7 Donegall Square West
    BT1 6JH Belfast

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0