KMB DEVELOPMENTS LIMITED

KMB DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKMB DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa NI027521
    JurisdicciónIrlanda del Norte
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Construcción de edificios domésticos (41202) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Grove
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    County Down
    Northern Ireland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2022

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2021

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2020

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2019

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2018

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 jun 2017

    2 páginasAA

    Resumen de ingresos y gastos del administrador judicial/gestor hasta 12 oct 2017

    2 páginas3.08(NI)

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    4 páginasRM02

    Resumen de ingresos y gastos del administrador judicial/gestor hasta 12 oct 2017

    2 páginas3.08(NI)

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    5 páginasRM02

    Resumen de ingresos y gastos del administrador judicial/gestor hasta 12 oct 2017

    2 páginas3.08(NI)

    Resumen de ingresos y gastos del administrador judicial/gestor hasta 12 oct 2017

    2 páginas3.08(NI)

    Resumen de ingresos y gastos del administrador judicial/gestor hasta 12 oct 2017

    2 páginas3.08(NI)

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    5 páginasRM02

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    5 páginasRM02

    Resumen de ingresos y gastos del administrador judicial/gestor hasta 12 oct 2017

    2 páginas3.08(NI)

    Notificación de cese de las funciones como administrador concursal o gestor

    5 páginasRM02

    ¿Quiénes son los directivos de KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KELLY, James Joseph
    11 Slievehanny Road
    Castlewellan
    BT33 0EJ Co Down
    Secretario
    11 Slievehanny Road
    Castlewellan
    BT33 0EJ Co Down
    Northern Irish145726900001
    BROWN, Colm
    11 Tullybrannigan Road
    Newcastle
    BT33 0HR Co Down
    Director
    11 Tullybrannigan Road
    Newcastle
    BT33 0HR Co Down
    Northern IrelandBritish145726880001
    KELLY, James Joseph
    11 Slievehanny Road
    Castlewellan
    BT33 0EJ Co Down
    Director
    11 Slievehanny Road
    Castlewellan
    BT33 0EJ Co Down
    Northern IrelandNorthern Irish145726900001
    MCEVOY, Gerry
    71 Shan Slieve Drive
    Newcastle
    BT33 0HN Co Down
    Director
    71 Shan Slieve Drive
    Newcastle
    BT33 0HN Co Down
    Northern IrelandBritish145726890001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Colm Brown
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    06 abr 2016
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Northern Ireland
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr James Joseph Kelly
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    06 abr 2016
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    No
    Nacionalidad: Northern Irish
    País de residencia: Northern Ireland
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr Gerry Mcevoy
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    06 abr 2016
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: Northern Ireland
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene KMB DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage and charge
    Creado el 04 feb 2010
    Entregado el 17 feb 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The lands and premises situate at and known as roslyn place, 20-26 bryansford road, newcastle, co. Down which said lands are comprised in folios DN112192, DN137239 and DN123327 all county down...see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 17 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 819 may 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 826 oct 2017Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 8
    Mortgage or charge
    Creado el 25 mar 2009
    Entregado el 01 abr 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. The lands and premises situate at and known as 42 ballinran road, kilkeel, co down which said lands are comprised in folio DN90903L co down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 01 abr 2009Registro de una carga (402 NI)
    • 719 may 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 726 oct 2017Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 7
    Mortgage or charge
    Creado el 19 mar 2009
    Entregado el 26 mar 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies charge on account. All of the company's rights, title and interest in and to the security account (as defined below) the deposit and the debts represented thereby.. The company covenants with the bank that during the continuance of the security created by the charge:-.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 26 mar 2009Registro de una carga (402R NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 30 may 2008
    Entregado el 03 jun 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. 5 tullybrannigan crescent, newcastle, co down in folio DN35502L co down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 03 jun 2008Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 14 abr 2008
    Entregado el 16 abr 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. The grove bar and lounge, 46-48 main street, castlewellan, co down comprised in folio DN151797 co down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 16 abr 2008Registro de una carga (402 NI)
    • 619 may 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 615 nov 2017Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 6
    Mortgage or charge
    Creado el 03 mar 2008
    Entregado el 19 mar 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies charge on account. All of the compay's rights, title and interest in and to the security account, the deposit and the debt represented thereby.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 19 mar 2008Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 03 mar 2008
    Entregado el 11 mar 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. 14 causeway road, newcastle, co down comprised in folio DN134280 co down. The lands and premises situate at and known as no 16 causeway road, newcastke, co down now known as good companions hall, causeway road, newcastle, co down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 11 mar 2008Registro de una carga (402 NI)
    • 519 may 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 515 nov 2017Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 5
    Mortgage or charge
    Creado el 11 jun 2007
    Entregado el 19 jun 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. All that parcel of land being part of the quarter of halftown of dromise or drumee next burren of maghera.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 19 jun 2007Registro de una carga (402 NI)
    • 419 may 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 426 oct 2017Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 4
    Mortgage or charge
    Creado el 05 jun 2007
    Entregado el 13 jun 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. " mount carmel ", 20 newcastle road, castlewellan, co down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 13 jun 2007Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 02 feb 2007
    Entregado el 14 feb 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. All that and those that dwelling house and premises situate in the town of newcastle in the townland of ballaghbeg parish of kilcoo barony of upper iveagh lower half and county of down together with all and singular the rights members and appurtenances to said premises belonging to appertaining" which said dwelling house is now known as no. 12 bryansford road, newcastle, co. Down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 14 feb 2007Registro de una carga (402 NI)
    • 319 may 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 326 oct 2017Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 3
    Mortgage or charge
    Creado el 18 oct 2006
    Entregado el 23 oct 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. The lands and premises comprised in folio DN107427 co down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 23 oct 2006Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 04 jul 2006
    Entregado el 06 jul 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. All that plot or piece of ground on the south west side of the country road leading from kilkeel to byransford , known as roslyn cottage, 28 bryansford road, newcastle, co down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 06 jul 2006Registro de una carga (402R NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 19 may 2006
    Entregado el 02 jun 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage and charge. 36,38 & 40 main street, annaghbeg, co down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 02 jun 2006Registro de una carga (402R NI)
    • 219 may 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 226 oct 2017Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 2
    Mortgage or charge
    Creado el 08 dic 2004
    Entregado el 13 dic 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage/charge and counterpart mortgage/charge.. 2.1 mortgages/fixed charges. The mortgagor as beneficial owner as a continuing security for the payment and discharge of the indebtedness hereby:-. (A) property:. (1) grants and demises unto the bank so much of the property as is unregistered land being "all that and those the lands and premises situate at castle avenue and clarmont avenue, castlewellan, county down more particularly comprised in deed of conveyance dated 13TH february 2004 and made between hugh joseph king (1) hugh joseph king, elizabeth frances king and peter malachy king (2) elizabeth frances king and james damien king (3) and the mortgagor (4) and described therein as. See 402 for further details.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 13 dic 2004Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 26 nov 2004
    Entregado el 01 dic 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    Al monies mortgage/charge. Folio no DN112204 county down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 01 dic 2004Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 03 feb 2004
    Entregado el 30 ene 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies solicitors letter of undertaking to hold in trust the original deeds of property situate at castle avenue and clarmont avenue, castlewellan, county down, which has been purchased by the company.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 30 ene 2004Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 07 nov 2003
    Entregado el 11 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies deed of charge a specific legal charge over the company's freehold and leasehold lands comprised in folio nos DN110635, DN100678L and DN110634L all county down.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 11 nov 2003Registro de una carga (402 NI)
    • 119 may 2016Nombramiento de un receptor o gerente (RM01)
    • 126 oct 2017Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (RM02)
      • Número de expediente 1
    Mortgage or charge
    Creado el 16 abr 2003
    Entregado el 25 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies mortgage/charge all that part of the lands and premises comprised in folio number DN33700 county down............................. See doc 44 for further details.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 25 abr 2003Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 20 ago 2002
    Entregado el 28 ago 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    Certain monies. A solicitor's letter of undertaking hold title deeds of hillyard house 1-5 castle avenue castlewellan county down to the order of ulster bank limited and to forward same upon completion of registration formalities.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 28 ago 2002Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 02 feb 2001
    Entregado el 16 feb 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Deed of mortgage. A specific mortgage over the company's freehold lands situate in the townland of tollymore barony of upper iveagh (lower half) and county of down more particularly described in indenture of conveyance dated the 2ND day of february 2001 and made between richard brian mclain of the one part and the company of the other part.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    • Belfast
    • Lombard & Ulster LTD
    Transacciones
    • 16 feb 2001Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 02 oct 2000
    Entregado el 10 oct 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    All monies. Debenture. 1(A) lands known as the quarry at castlewellan road, dundrum, county down containing approx. 2 acres 3 roods. (B) lands at dromara road, dundrum county down containing 3.85 acres or thereabouts see doc 33 for further details.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 10 oct 2000Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 02 ago 2000
    Entregado el 11 ago 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    A specific mortgage over the company's freehold lands situate on the west side of main street, dundrum, parish of kilmegan, barony of lecale and county of down more particularly described in indenture of conveyance dated the 2ND day of august 2000 and made between brian maguire and keith toner of the one part and the company of the other part.
    Personas con derecho
    • Lombard & Ulster LTD
    • Ulster Bank Limited
    Transacciones
    • 11 ago 2000Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 14 may 1999
    Entregado el 17 may 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    Deed of mortgage - all monies a specific legal mortgage over the company's freehold land situate in the townland of dundrum barony of lecale upper and county of down more particularly described in indenture of conveyance dated the 17TH day of march 1921 and made between the most honourable the marquis of downshire (1) the right honourable william hill and the honourable charles edward hill trevor (2) and john mccafferty (3).
    Personas con derecho
    • Lombard & Ulster
    • Ulster Bank LTD
    Transacciones
    • 17 may 1999Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 30 abr 1999
    Entregado el 10 may 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    0
    Breve descripción
    Mortgage. No. 64 carrigvale, dromara road, dundrum co down.
    Personas con derecho
    • First Active
    Transacciones
    • 10 may 1999Registro de una carga (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creado el 08 sept 1997
    Entregado el 26 sept 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    112000
    Breve descripción
    Mortgage the companys premises known as lot 61 in the townland of dundrum the quarry at castlewellan road, dundrum and dromara road dundrum. See doc 22 for further details.
    Personas con derecho
    • Irish Nationwide
    Transacciones
    • 26 sept 1997Registro de una carga (402 NI)

    ¿Tiene KMB DEVELOPMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Administrador judicial/gestor
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Administrador judicial/gestor
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    2Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Administrador judicial/gestor
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Administrador judicial/gestor
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    3Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Administrador judicial/gestor
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Administrador judicial/gestor
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    4Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Administrador judicial/gestor
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Administrador judicial/gestor
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    5Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Administrador judicial/gestor
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Administrador judicial/gestor
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    6Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Administrador judicial/gestor
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Administrador judicial/gestor
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    7Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Administrador judicial/gestor
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Administrador judicial/gestor
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    8Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Administrador judicial/gestor
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Administrador judicial/gestor
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0